Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 5 tarjetas
13/10/2016 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-412504

Reelecciones — 13/10/2016

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 12533 , F 166, S 8, H M 70615, I/A 162 ( 4.10.16).

16/09/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-377677

Nombramientos — 16/09/2015

Nombramientos. Apo.Sol.: HORNOS PRADOS GUSTAVO. Datos registrales. T 12533 , F 162, S 8, H M 70615, I/A 157 ( 9.09.15).

20/02/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-77044

Nombramientos — 20/02/2015

Nombramientos. Apoderado: LOZANO RODRIGUEZ IVAN FEDERICO;VON PRABUCKI HURTADO CARLOS;MARTIN TERESO DIAZ ANTONIO FRANCISCO;CANTON POLINIO GREGORIO;HITOS DE CARDENAS EDUARDO;LLANOS CID MONTSERRAT. Datos registrales. T 125...

03/10/2013 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-424186

Reelecciones — 03/10/2013

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 12533 , F 154, S 8, H M 70615, I/A 144 (25.09.13).

03/08/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-322995

Ceses/dimisiones — 03/08/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: LEPERT MICHEL PAUL AUGUSTE. Presidente: LEPERT MICHEL PAUL AUGUSTE. Datos registrales. T 12533 , F 145, S 8, H M 70615, I/A 128 (20.07.11).