Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2017 6 tarjetas
09/02/2017 Sec. I Extinción Burgos
Burgos-65026

Extinción — 09/02/2017

Extinción. Datos registrales. T 361, L 152, F 131, S 8, H BU 1182, I/A 10 ( 2.02.17).

08/04/2014 Sec. I Nombramientos Burgos
Burgos-155612

Nombramientos — 08/04/2014

Nombramientos. Auditor: AAB AUDIT MANCHA SLP. Datos registrales. T 244, L 35, F 121, S 8, H BU 1182, I/A 7 ( 1.04.14).

27/05/2013 Sec. I Nombramientos Burgos
Burgos-241718

Nombramientos — 27/05/2013

Nombramientos. Auditor: SERNA DIAZ GERARDO. Datos registrales. T 244, L 35, F 121, S 8, H BU 1182, I/A 6 (21.05.13).

18/06/2012 Sec. I Nombramientos Burgos
Burgos-255426

Nombramientos — 18/06/2012

Nombramientos. Auditor: GALLO PALACIOS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 244, L 35, F 121, S 8, H BU 1182, I/A 5 ( 7.06.12).

25/05/2011 Sec. I Nombramientos Burgos
Burgos-222890

Nombramientos — 25/05/2011

Nombramientos. Auditor: GARCIA PEREZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 244, L 35, F 121, S 8, H BU 1182, I/A 4 (17.05.11). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

23/02/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Burgos
Burgos-82098

Ceses/dimisiones — 23/02/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: RENUNCIO GALIANA EUTIQUIO. Secretario: RENUNCIO GALIANA BENITO. Presidente: RENUNCIO GALIANA EUTIQUIO. Consejero: RENUNCIO GALIANA BENITO;RENUNCIO GALIANA CRISTINA;RENUNCIO GALIANA CECILIA;R...