Actos destacados
Reelecciones — 14/09/2017
Reelecciones. Adm. Unico: DIEGO ZAMORA SA. Modificaciones estatutarias. Modificado el artículo 9º de los estatutos sociales, relativo al a duración del cargo. Otros conceptos: El administrador ejercerá su cargo por plaz...
Nombramientos — 14/09/2017
Nombramientos. Apo.Sol.: AYALA SANCHEZ ANDRES JOSE;FANLO GOMEZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 670 , F 225, S 8, H LO 2046, I/A 85 ( 4.09.17).
Nombramientos — 18/08/2017
Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ VIVANCOS QUERUBINA. Datos registrales. T 670 , F 225, S 8, H LO 2046, I/A 83 ( 8.08.17).
Reelecciones — 08/11/2016
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 670 , F 225, S 8, H LO 2046, I/A 82 (27.10.16).
Nombramientos — 26/08/2016
Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ VIVANCOS QUERUBINA. Datos registrales. T 670 , F 220, S 8, H LO 2046, I/A 77 (12.08.16).
Nombramientos — 26/08/2016
Nombramientos. Apoderado: DE COIG O'DONNELL LOPEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 670 , F 221, S 8, H LO 2046, I/A 78 (12.08.16).
Nombramientos — 26/08/2016
Nombramientos. Apoderado: BASTIDA CARO RODOLFO. Datos registrales. T 670 , F 221, S 8, H LO 2046, I/A 79 (12.08.16).
Nombramientos — 26/08/2016
Nombramientos. Apoderado: GUERRA FAGALDE LORENZO IGNACIO. Datos registrales. T 670 , F 222, S 8, H LO 2046, I/A 80 (12.08.16).
Nombramientos — 26/08/2016
Nombramientos. Apoderado: GALINDO BROCAL JUAN JOSE. Datos registrales. T 670 , F 223, S 8, H LO 2046, I/A 81 (12.08.16).
Otros conceptos: se modifica el domicilio social en virtud de certificación expedida el 6/11/2015 por el ayuntamiento de haro, en la que consta que la carretera de casalarreina desde el 28/11/1975 pasó a denominarse avda — 08/01/2016
Otros conceptos: Se modifica el domicilio social en virtud de certificación expedida el 6/11/2015 por el Ayuntamiento de Haro, en la que consta que la carretera de Casalarreina desde el 28/11/1975 pasó a denominarse Avd...
Nombramientos — 23/10/2015
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 670 , F 220, S 8, H LO 2046, I/A 76 (16.10.15). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Nombramientos — 12/11/2014
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 670 , F 220, S 8, H LO 2046, I/A 75 ( 4.11.14).
Nombramientos — 08/01/2014
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 670 , F 220, S 8, H LO 2046, I/A 74 (23.12.13).
Nombramientos — 05/08/2013
Nombramientos. Apoderado: CLAMENS THOMAS DANIEL MICHEL. Datos registrales. T 670 , F 220, S 8, H LO 2046, I/A 73 (26.07.13).
Nombramientos — 29/11/2012
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 519 , F 145, S 8, H LO 2046, I/A 72 (20.11.12).
Ceses/dimisiones — 10/08/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: RESTOY ZAMORA EMILIO. Presidente: RESTOY ZAMORA EMILIO. Consejero: RESTOY CABRERA EMILIO;BASTIDA CARO RODOLFO. SecreNoConsj: LOPEZ ORTEGA ASCENSION. Nombramientos. Adm. Unico: DIEGO ZAMORA S...
Nombramientos — 12/07/2012
Nombramientos. Apoderado: GINE DOMINGUEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 519 , F 145, S 8, H LO 2046, I/A 70 ( 2.07.12).
Ceses/dimisiones — 24/05/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA CONESA JOSE;PEREZ LLORENTE CARLOS. Secretario: PEREZ LLORENTE CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj: LOPEZ ORTEGA ASCENSION. Datos registrales. T 519 , F 144, S 8, H LO 2046, I/A 69 (11...
Reelecciones — 14/10/2011
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 519 , F 144, S 8, H LO 2046, I/A 68 ( 4.10.11).
Nombramientos — 12/08/2011
Nombramientos. Apo.Sol.: RESTOY CABRERA EMILIO;GALINDO BROCAL JUAN JOSE. Datos registrales. T 519 , F 144, S 8, H LO 2046, I/A 67 ( 3.08.11).
Nombramientos — 14/03/2011
Nombramientos. Apoderado: RESTOY CABRERA EMILIO. Datos registrales. T 519 , F 143, S 8, H LO 2046, I/A 65 ( 1.03.11).
Revocaciones — 14/03/2011
Revocaciones. Apo.Sol.: RESTOY ZAMORA EMILIO. Datos registrales. T 519 , F 144, S 8, H LO 2046, I/A 66 ( 1.03.11).
Nombramientos — 23/12/2010
Nombramientos. Consejero: BASTIDA CARO RODOLFO. Datos registrales. T 519 , F 143, S 8, H LO 2046, I/A 64 (14.12.10).
Ampliación de capital — 13/08/2010
Ampliación de capital. Suscrito: 306.510,00 Euros. Desembolsado: 306.510,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.710.510,00 Euros. Resultante Desembolsado: 2.710.510,00 Euros. Datos registrales. T 519 , F 142, S 8, H LO 2046,...