Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2014 6 tarjetas
13/11/2014 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-458849

Nombramientos — 13/11/2014

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44576 , F 11, S 8, H B 160105, I/A 59 ( 4.11.14).

31/10/2014 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-439442

Revocaciones — 31/10/2014

Revocaciones. APODERADO: NIÑO BOSCH FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 42055 , F 198, S 8, H B 160105, I/A 57 (23.10.14).

31/10/2014 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-439443

Nombramientos — 31/10/2014

Nombramientos. APOD.MANCOMU: LUIS ALBERTO SILVA FERNANDES. Datos registrales. T 42055 , F 198, S 8, H B 160105, I/A 58 (23.10.14).

22/11/2012 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-479864

Nombramientos — 22/11/2012

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Reducción de capital. Importe reducción: 8.078.182,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.921.818,00 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 3.078.182,00 Euros. Desembolsado: 3.078.18...

25/09/2009 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-408112

Nombramientos — 25/09/2009

Nombramientos. APODERADO: FERRER FIGUERAS FRANCISCO. Datos registrales. T 36446 , F 107, S 8, H B 160105, I/A 44 (14.09.09).

30/06/2009 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-294371

Nombramientos — 30/06/2009

Nombramientos. CONSEJERO: ANGELO BARBEDO CESAR MACHADO. Datos registrales. T 36446 , F 107, S 8, H B 160105, I/A 42 (17.06.09).