Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 24 tarjetas
24/06/2016 Sec. I Cambio de denominación social Madrid
Madrid-267610

Cambio de denominación social — 24/06/2016

Cambio de denominación social. WIZINK BANK SA. Datos registrales. T 34440 , F 175, S 8, H M 198598, I/A 262 (17.06.16).

18/03/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-126918

Nombramientos — 18/03/2016

Nombramientos. Apoderado: DEL CAZ MORENO RAMON. Datos registrales. T 30454 , F 220, S 8, H M 198598, I/A 255 ( 9.03.16).

18/03/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-126919

Nombramientos — 18/03/2016

Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ CALABOZO JOSE MIGUEL;RIVIERE GUIMARAES COTTA BRUNO;ALVAREZ PLANAS REGINA;CARMONA JIMENEZ OLGA;PEREZ SIMON TERESA;PLANAS DE LA CAMARA LUIS;PINTOS CASADO TRINIDAD;FERNANDEZ MAZA MANUEL MARI...

18/03/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-126920

Revocaciones — 18/03/2016

Revocaciones. Apoderado: SERRANO OSUNA ANA ISABEL. Apo.Man.Soli: GONZALEZ MUÑOZ ANA ISABEL. Apoderado: BARQUIER SALAS ANA MARIA;DIAZ SALINAS MIGUEL CARLOS;BALLESTEROS ARGUELLO FRANCISCO JAVIER. Apo.Man.Soli: GONZALEZ GA...

18/03/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-126921

Nombramientos — 18/03/2016

Nombramientos. Apoderado: ESNAOLA ALEGRIA NEREA. Datos registrales. T 30454 , F 222, S 8, H M 198598, I/A 258 ( 9.03.16).

25/01/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-30183

Revocaciones — 25/01/2016

Revocaciones. Apo.Man.Soli: CADARSO SANTAOLALLA EUGENIA;DOMINGUEZ NIETO RAMON EUGENIO;FERREIRA PEREZ LUIS;GARCIA GARCIA FRANCISCO;GARRIDO GUTIERREZ MANUEL;GIL MARTINEZ PEDRO MARIA;GUILLEN MONTOYA NEREA;HORMAECHE SANTIAG...

14/01/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-13285

Revocaciones — 14/01/2016

Revocaciones. Apo.Man.Soli: AGUILERA LOPEZ JOSE MIGUEL;ARESTI MUGICA REGINA;ARIÑO GARCIA JAIME;BLANCO LOPEZ JOSE ANTONIO;BRAVO PLANA-SALA PATRICIA;CACERES MARTIN LUIS;DIAZ ESCORIAL ALBERTO;DIAZ GARCIA FUENTES MIGUEL;GAR...

17/12/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-511898

Revocaciones — 17/12/2015

Revocaciones. Apo.Man.Soli: DURAN LOPEZ ANA ISABEL;GUTIERREZ DE SOLA SUSANA;SANTOS FENTE LARA. Apoderado: ROMERO GONZALEZ ROCIO. Datos registrales. T 30454 , F 218, S 8, H M 198598, I/A 251 ( 9.12.15).

17/12/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-511899

Nombramientos — 17/12/2015

Nombramientos. Apoderado: GRAS ARNEDO EUSEBIA;MORALES RODRIGUEZ NEREA;COLADO FERNANDEZ SARA ESPERANZA. Datos registrales. T 30454 , F 218, S 8, H M 198598, I/A 252 ( 9.12.15).

23/11/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-472825

Nombramientos — 23/11/2015

Nombramientos. Apoderado: PERKINS DEL VALLE RICHARD IÑAKI. Apo.Sol.: RAMOS ROBLEDO EMILIO;FERNANDEZ MAZA MANUEL. Datos registrales. T 30454 , F 216, S 8, H M 198598, I/A 248 (13.11.15).

23/11/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-472826

Nombramientos — 23/11/2015

Nombramientos. Apo.Sol.: PERKINS DEL VALLE RICHARD IÑAKI;RAMOS ROBLEDO EMILIO;FERNANDEZ MAZA MANUEL. Datos registrales. T 30454 , F 217, S 8, H M 198598, I/A 249 (16.11.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 2...

30/10/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-438362

Ceses/dimisiones — 30/10/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE MEDRANO BOIX SUSANA. Nombramientos. Consejero: PIÑEIRO BECERRA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 30454 , F 213, S 8, H M 198598, I/A 244 (23.10.15).

25/09/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-388932

Revocaciones — 25/09/2015

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALFARO ADRIAN BEGOÑA;AYLAGAS HERNANDEZ LUIS ANGEL;PACHECO JIMENEZ VIRGINIA. Datos registrales. T 30454 , F 210, S 8, H M 198598, I/A 240 (16.09.15).

25/09/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-388933

Nombramientos — 25/09/2015

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ GARCIA VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 30454 , F 211, S 8, H M 198598, I/A 241 (16.09.15).

08/09/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-366642

Nombramientos — 08/09/2015

Nombramientos. Apo.Sol.: MODREGO HUIDOBRO ANA CRISTINA;URIZOLA SAENZ MARIA-TERESA;VICTORIO PALOMAR PATRICIA;CASADO MORENO MARIA JESUS;DE INZA MUÑOZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 30454 , F 210, S 8, H M 198598,...

08/09/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-366643

Nombramientos — 08/09/2015

Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ ARES IRIS. Datos registrales. T 30454 , F 210, S 8, H M 198598, I/A 239 (26.08.15).

30/06/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-268286

Revocaciones — 30/06/2015

Revocaciones. Apo.Sol.: ALONSO LOBO JOSE RAMON. Apo.Man.Soli: ALBA BRAVO MARIA ROSARIO;CARRION BOULOS BEATRIZ;CELESTINO VALLADARES BEATRIZ;ORTIZ PERALVO RAFAEL;RODRIGUEZ MARTIN NATALIA;SANCHEZ VAHL MARIA;REÑONES VAZQUEZ...

17/02/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-70394

Ceses/dimisiones — 17/02/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: ESTEVEZ PUERTO JOSE RAMON;MONTUENGA BADIA JOSE MARIA;OSUNA PEDREGOSA NICOLAS;NIGORRA COBIAN LUIS;MORALES LOPEZ EUTIMIO;GANCEDO HOLMER ERIC. Presidente: GANCEDO HOLMER ERIC. Consejero: STECHE...

15/01/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-13805

Revocaciones — 15/01/2015

Revocaciones. Apo.Man.Soli: AMPIEE VIGIL MARIA DEL CARMEN;DE MAZARREDO BAILON EUGENIO;DIAZ GOMEZ JESUS MARIA;HUETE LOPEZ FERNANDO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: REYNES ALVAREZ JUAN;REÑONES VAZQUEZ VANESSA;MARIN GARIJO AN...

10/10/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-406701

Nombramientos — 10/10/2014

Nombramientos. Apoderado: SANTOS CERMEÑO VIRGINIA;GONZALEZ VEIGA ANA MARIA;SANCHEZ GANDARIAS MONICA;POLO JIMENEZ DOROTEO MARTIN;CEVERINO CURIEL MANUEL PEDRO;VIVAS SOTILLOS CARLOS;DIAZ SALINAS MIGUEL CARLOS;BURGOS RODRIG...

22/09/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-374927

Nombramientos — 22/09/2014

Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUILERA LOPEZ JOSE MIGUEL;ALBA BRAVO MARIA ROSARIO;ALFARO ESCOLAR MONICA;ALFARO ADRIAN BEGOÑA;ALONSO GUILLEN ERIKA;ALVAREZ COTRONEO FIDEL IGNACIO;ALVAREZ PLAZA JOSE MANUEL;AMPIEE VIGIL MARI...

22/09/2014 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-374928

Ampliación de capital — 22/09/2014

Ampliación de capital. Suscrito: 38.117.166,00 Euros. Desembolsado: 38.117.166,00 Euros. Resultante Suscrito: 105.548.246,00 Euros. Resultante Desembolsado: 105.548.246,00 Euros. Datos registrales. T 30454 , F 176, S 8,...

22/09/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-374929

Nombramientos — 22/09/2014

Nombramientos. Apoderado: PERKINS DEL VALLE RICHARD IÑAKI. Datos registrales. T 30454 , F 177, S 8, H M 198598, I/A 206 (15.09.14).

08/08/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-327219

Nombramientos — 08/08/2014

Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ BELLIDO RAFAEL. Datos registrales. T 30454 , F 167, S 8, H M 198598, I/A 200 (30.07.14).