Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2014 24 tarjetas
04/06/2014 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-235496

Revocaciones — 04/06/2014

Revocaciones. Apoderado: SANTOS LOPEZ JOSE VICENTE. Datos registrales. T 31571 , F 25, S 8, H M 522312, I/A 89 (28.05.14).

04/06/2014 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-235497

Revocaciones — 04/06/2014

Revocaciones. Apo.Man.Soli: COMUNION ARTIEDA JAIME. Apoderado: COMUNION ARTIEDA JAIME. Datos registrales. T 31571 , F 25, S 8, H M 522312, I/A 90 (28.05.14).

26/02/2014 Sec. I Otros conceptos: SE SUBSANA EL DNI/NIF DEL APODERADO DON LEOPOLDO ALVEAR TRENOR, NOMBRADO MEDIANTE ESCRITURAS QUE CAUSARON LAS INSCRIPCIONES 22& Y 29&, RESPECTIVAMENTE, SIENDO EL CORRECTO: 51404562-E Madrid
Madrid-90522

Otros conceptos: se subsana el dni/nif del apoderado don leopoldo alvear trenor, nombrado mediante escrituras que causaron las inscripciones 22& y 29&, respectivamente, siendo el correcto: 51404562-e — 26/02/2014

Otros conceptos: SE SUBSANA EL DNI/NIF DEL APODERADO DON LEOPOLDO ALVEAR TRENOR, NOMBRADO MEDIANTE ESCRITURAS QUE CAUSARON LAS INSCRIPCIONES 22& Y 29&, RESPECTIVAMENTE, SIENDO EL CORRECTO: 51404562-E. Datos registrales....

10/02/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-61296

Nombramientos — 10/02/2014

Nombramientos. Apoderado: MAESTRE MANTECA MARIA VISITACION;ARBAS REINA FRANCISCO;FERNANDEZ MIGUEL CARLOS. Datos registrales. T 31571 , F 10, S 8, H M 522312, I/A 84 (31.01.14).

05/02/2014 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-53271

Revocaciones — 05/02/2014

Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ GOMEZ MARIA EUGENIA;DIEZ GOMEZ MARIA SOLEDAD. Apo.Man.Soli: ANTON HUESO MARIA NIEVES. Datos registrales. T 31571 , F 10, S 8, H M 522312, I/A 83 (27.01.14).

11/12/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-528826

Revocaciones — 11/12/2013

Revocaciones. Apo.Man.Soli: BARTOLOME PASARO JUAN MARTIN. Apoderado: MOLLA CARAZZONI DIEGO;ARA SAIZ FRANCISCO;GOMEZ LOPEZ MARIA JESUS;OZORES SERRA JOSE MANUEL;PASCUAL LLOPIS JOAN FRANCESC;IBAÑEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN....

11/12/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-528827

Revocaciones — 11/12/2013

Revocaciones. Apoderado: ALCORTA DIEZ MARIA;IZQUIERDO JIMENEZ BORJA;ALVAREZ CONEJERO EMILIO;BARTOLOME DELICADO JUAN CARLOS;BASURCO GARCIA-CASAL IGNACIO;BENAZCO FERNANDEZ LEONOR;CABANILLAS REJA ANTONIO;CABRERA PADRON JON...

02/12/2013 Sec. I Otros conceptos: INSERTADO CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, EN LA PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD " BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS SA " ( www Madrid
Madrid-513480

Otros conceptos: insertado con fecha 21 de noviembre de 2013, en la pagina web de la sociedad " banco financiero y de ahorros sa " ( www — 02/12/2013

Otros conceptos: INSERTADO CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, EN LA PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD " BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS SA " ( www.bancofinancieroydeahorros.com ), el proyecto de Fusion de dicha Sociedad como Soci...

28/10/2013 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-460236

Modificaciones estatutarias — 28/10/2013

Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 29006 , F 225, S 8, H M 522312, I/A 74 (18.10.13).

02/08/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-347504

Nombramientos — 02/08/2013

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ LAGUNA OCTAVIO MIGUEL. Datos registrales. T 29006 , F 217, S 8, H M 522312, I/A 67 (25.07.13).

02/08/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-347505

Nombramientos — 02/08/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: GESTORIA MONTALVO SLP;MUNDIGESTION ECONOMICA Y FISCAL SLP;GESTORIA PINOS XXI SL;GUTIERREZ LABRADOR SL. Datos registrales. T 29006 , F 223, S 8, H M 522312, I/A 68 (25.07.13).

02/08/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-347506

Revocaciones — 02/08/2013

Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ FERNANDEZ RAQUEL INES;PEREZ OLMEDA MARIA FERNANDA;RUIZ-SANTAQUIRERIA PEÑA PASCUAL;SAMPEDRO ECHARRI JUAN CARLOS;LOPEZ RODENAS PEDRO;MARTIN BRIESKORN BEATRIZ. Datos registrales. T 29006 ,...

17/07/2013 Sec. I Otros conceptos: Con fecha 4 de julio de 2012, fue amorizada parcialmente por importe de 25 Madrid
Madrid-322565

Otros conceptos: con fecha 4 de julio de 2012, fue amorizada parcialmente por importe de 25 — 17/07/2013

Otros conceptos: Con fecha 4 de julio de 2012, fue amorizada parcialmente por importe de 25.131.000 Euros, la " Cuarta Emisión de BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 134 Miércoles 17 de julio de 2013 Pág. 34707...

10/04/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-168627

Revocaciones — 10/04/2013

Revocaciones. Apoderado: POZO LOZANO LUIS. Datos registrales. T 29006 , F 184, S 8, H M 522312, I/A 55 ( 2.04.13).

10/04/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-168628

Nombramientos — 10/04/2013

Nombramientos. Apoderado: MARTIN VELAYOS JOSE LUIS. Datos registrales. T 29006 , F 184, S 8, H M 522312, I/A 56 ( 2.04.13). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 67 Miércoles 10 de abril de 2013 Pág. 17753 cve: BO...

09/10/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-412248

Revocaciones — 09/10/2012

Revocaciones. Apoderado: MARTIN GIL LUIS MIGUEL;NIELLA CABALLE CARLOS;PORTILLO GIRON MARIA DE LOS ANGELES;PUIGVER COBOS COSME DAVID;FERNANDEZ MELLE MANUEL;GARCIA AGULLA EUGENIO;SANCHEZ MURIARTE ADELA SOLEDAD;VARAS DE LA...

09/10/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-412249

Nombramientos — 09/10/2012

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ JIMENEZ MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 29006 , F 167, S 8, H M 522312, I/A 47 (28.09.12).

03/10/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-403426

Nombramientos — 03/10/2012

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ANTON HUESO MARIA NIEVES;BADILLO JIMENEZ FERNANDO AUGUST;CRUZ REDONDO MARIA-ISABEL;DE LA CRUZ VALENTIN FERNANDEZ LUIS MIGUEL;DIAZ GONZALEZ JOSE MIGUEL;GONZALEZ QUINTANA DANIEL;GUADIX CASTRO...

03/10/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-403427

Revocaciones — 03/10/2012

Revocaciones. Apo.Man.Soli: COBO BARROSO MANUEL. Apoderado: RODRIGUEZ LEON JOSE MANUEL. Datos registrales. T 29006 , F 166, S 8, H M 522312, I/A 45 (22.09.12).

26/09/2012 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-394754

Ampliación de capital — 26/09/2012

Ampliación de capital. Suscrito: 4.500.000.000,00 Euros. Desembolsado: 4.500.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.528.000.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 4.528.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 29006 , F...

31/07/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-321303

Ceses/dimisiones — 31/07/2012

Ceses/Dimisiones. MiCoAudi: ACEBES PANIAGUA ANGEL. Consejero: ACEBES PANIAGUA ANGEL. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 31 LA PUBLICACION DE LA DIMISION COMO CONSEJERO DE DON ANGEL ACEBES PANIAGUA. Dat...

31/07/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-321304

Nombramientos — 31/07/2012

Nombramientos. Apoderado: MAGNET O'DOGHERTY FERNANDO;GARRIDO VALDIVIELSO MANUEL. Datos registrales. T 29006 , F 149, S 8, H M 522312, I/A 37 (20.07.12).

12/07/2012 Sec. I Declaración de unipersonalidad Madrid
Madrid-295314

Declaración de unipersonalidad — 12/07/2012

Declaración de unipersonalidad. Socio único: FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA. Reducción de capital. Importe reducción: 27.040.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 2...

29/05/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-227362

Nombramientos — 29/05/2012

Nombramientos. Apoderado: BELTRAN TRELL JORDI;CRUZADO PICON MARTA DE LAS FLORES;DONAIRE BABIANO SILVIA;GUTIERREZ CARANDE PATRICIA;HERNANDEZ BENITO JUAN;IBAÑEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN;LOPEZ-NIÑO CARNICER ROSA MARIA;MARTIN...