Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 5 tarjetas
20/11/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-479721

Ceses/dimisiones — 20/11/2019

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PEREZ RAMIREZ ANTONIO;DE CEVALLOS DE DIEGO CARLOS. Nombramientos. LiquiSoli: DE CEVALLOS DE DIEGO CARLOS;PEREZ RAMIREZ ANTONIO. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 2828...

07/04/2017 Sec. I Reducción de capital Madrid
Madrid-157285

Reducción de capital — 07/04/2017

Reducción de capital. Importe reducción: 13.657.100,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.104.600,00 Euros. Datos registrales. T 28288 , F 45, S 8, H M 509490, I/A 11 (30.03.17).

03/03/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-103014

Nombramientos — 03/03/2017

Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28288 , F 45, S 8, H M 509490, I/A 10 (22.02.17). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 44 Viernes 3 de marzo de 2017 Pág. 10891 cv...

10/02/2016 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-59871

Reelecciones — 10/02/2016

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28288 , F 45, S 8, H M 509490, I/A 9 ( 1.02.16).

14/11/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-462233

Nombramientos — 14/11/2014

Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28288 , F 44, S 8, H M 509490, I/A 7 ( 6.11.14).