Actos destacados
Revocaciones — 31/10/2019
Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ BELLES PEDRO JOSE. Apo.Sol.: LOPEZ BELLES PEDRO JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ BELLES PEDRO JOSE. Apo.Manc.: LOPEZ BELLES PEDRO JOSE;THORSEN HILDE. Apo.Sol.: THORSEN HILDE. Datos reg...
Reelecciones — 12/02/2019
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4221 , F 165, S 8, H AS 8064, I/A 30 ( 4.02.19).
Ceses/dimisiones — 26/06/2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARTINEZ VALLEJO LLUIS. Consejero: ALEMAN GUTIERREZ CARLOS;LAVIN SERRA JOAQUIN. Presidente: ALEMAN GUTIERREZ CARLOS. Consejero: MIKEY EITAN. Nombramientos. SecreNoConsj: LOPEZ BELLES PEDR...
Modificaciones estatutarias — 26/06/2018
Modificaciones estatutarias. 21. Organización de la administración de la sociedad.-. Datos registrales. T 4221 , F 164, S 8, H AS 8064, I/A 27 (18.06.18).
Revocaciones — 26/06/2018
Revocaciones. Apo.Sol.: LAVIN SERRA JOAQUIN. Apo.Manc.: LAVIN SERRA JOAQUIN. Nombramientos. Apo.Sol.: GOLDBERG EDWARD. Datos registrales. T 4221 , F 164, S 8, H AS 8064, I/A 28 (18.06.18).
Sociedad unipersonal — 26/06/2018
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: SK INV SPAIN SL. Datos registrales. T 4221 , F 165, S 8, H AS 8064, I/A 29 (18.06.18). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 121 Martes 26 de junio de 201...
Revocaciones — 20/03/2018
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ ALAMO JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: MARTINEZ ALAMO JOSE ANTONIO. Apo.Sol.: COTS MUNCUNILL FRANCESC. Apo.Manc.: COTS MUNCUNILL FRANCESC. Apo.Sol.: GUELL CARDONA JOAN. Apo.Manc.: GUELL CARDONA...
Ceses/dimisiones — 30/11/2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: COTS MUNCUNILL FRANCESC. Vicepresid.: COTS MUNCUNILL FRANCESC. Nombramientos. Consejero: MIKEY EITAN. Datos registrales. T 4221 , F 160, S 8, H AS 8064, I/A 24 (20.11.17).
Ceses/dimisiones — 25/07/2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ ALAMO JOSE ANTONIO;GUELL CARDONA JOAN. Presidente: MARTINEZ ALAMO JOSE ANTONIO. Secretario: GUELL CARDONA JOAN. Nombramientos. Consejero: ALEMAN GUTIERREZ CARLOS;LAVIN SERRA JOAQUIN...
Nombramientos — 13/12/2016
Nombramientos. Vicepresid.: COTS MUNCUNILL FRANCESC. Datos registrales. T 4221 , F 160, S 8, H AS 8064, I/A 22 (30.11.16).
Nombramientos — 25/08/2016
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1528 , F 225, S 8, H AS 8064, I/A 21 (17.08.16).
Revocaciones — 13/05/2016
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ ALAMO JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: MARTINEZ ALAMO JOSE ANTONIO. Apo.Sol.: COTS MUNCUNILL FRANCESC. Apo.Manc.: COTS MUNCUNILL FRANCESC. Apo.Sol.: GUELL CARDONA JOAN. Apo.Manc.: GUELL CARDONA...
Nombramientos — 05/11/2014
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ VALLEJO LLUIS. Datos registrales. T 1528 , F 223, S 8, H AS 8064, I/A 19 (28.10.14).
Ceses/dimisiones — 10/06/2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ACUÑA VEGA ANTONIO;ACUÑA ALLER ANTONIO. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ ALAMO JOSE ANTONIO;COTS MUNCUNILL FRANCESC;GUELL CARDONA JOAN. Presidente: MARTINEZ ALAMO JOSE ANTONIO. Secretari...
Nombramientos — 10/06/2014
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ ALAMO JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: MARTINEZ ALAMO JOSE ANTONIO. Apo.Sol.: COTS MUNCUNILL FRANCESC. Apo.Manc.: COTS MUNCUNILL FRANCESC. Apo.Sol.: GUELL CARDONA JOAN. Apo.Manc.: GUELL CARDONA...
Declaración de unipersonalidad — 10/06/2014
Declaración de unipersonalidad. Socio único: ICL IBERIA LIMITED SOCIEDAD COMANDITARIA SIMPLE. Datos registrales. T 1528 , F 223, S 8, H AS 8064, I/A 18 (30.05.14).
Reelecciones — 20/02/2012
Reelecciones. Adm. Solid.: ACUÑA VEGA ANTONIO;ACUÑA ALLER ANTONIO. Datos registrales. T 1528 , F 112, S 8, H AS 8064, I/A 15 ( 8.02.12).