Actos destacados
Nombramientos — 02/12/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: CASTRO CAMPOS CONSTANTINO;FONDEVILA SUAREZ JAVIER;SANZ BRAVO JUAN MARIA;LOUZAN ALVAREZ MARCOS. Datos registrales. T 2612 , F 69, S 8, H C 4473, I/A 222 (24.11.15).
Reelecciones — 11/11/2015
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2612 , F 68, S 8, H C 4473, I/A 221 (30.10.15).
Reelecciones — 31/07/2015
Reelecciones. Consejero: LENCE MORENO RICARDO;LOPEZ VERDEJO JUAN CARLOS;DIAZ PEÑA ALBERTO;ENAITINERE SL;PUELLES GALLO JOSE. Presidente: LOPEZ VERDEJO JUAN CARLOS. Consejero: ARECIBO SERVICIOS Y GESTIONES SL;JIMENEZ ORTI...
Reelecciones — 06/07/2015
Reelecciones. Miem.ComAyR.: ARECIBO SERVICIOS Y GESTIONES SL;LENCE MORENO RICARDO;PUELLES GALLO JOSE. Consejero: ARECIBO SERVICIOS Y GESTIONES SL. Datos registrales. T 2612 , F 68, S 8, H C 4473, I/A 217 (29.06.15).
Nombramientos — 04/05/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: CASTRO CAMPOS CONSTANTINO;FONDEVILA SUAREZ JAVIER;LOUZAN ALVAREZ MARCOS;SANZ BRAVO JUAN MARIA. Datos registrales. T 2612 , F 67, S 8, H C 4473, I/A 216 (20.04.15).
Otros conceptos: la accionista única de esta sociedad "empresa nacional de autopistas, s — 17/11/2014
Otros conceptos: La accionista única de esta sociedad "EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTAS, S.A." ha cambiado su denominación social por la de "ENA INFRAESTRUCTURAS, S.A.".- Datos registrales. T 2612 , F 67, S 8, H C 4473, I...
Reelecciones — 17/11/2014
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2612 , F 67, S 8, H C 4473, I/A 214 (10.11.14).
Ceses/dimisiones — 03/06/2014
Ceses/Dimisiones. P.Com.AyR: PUELLES GALLO JOSE. Nombramientos. P.Com.AyR: ARECIBO SERVICIOS Y GESTIONES SL. Datos registrales. T 2612 , F 67, S 8, H C 4473, I/A 212 (27.05.14).
Reelecciones — 19/11/2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2612 , F 66, S 8, H C 4473, I/A 210 (13.11.13).
Ceses/dimisiones — 05/08/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: MUNTANER PEDROSA ANDRES. Datos registrales. T 2612 , F 66, S 8, H C 4473, I/A 209 (29.07.13). 349188 - AUTOESTRADAS DE GALICIA AUTOPISTAS DE GALICIA CONCESIONARIA DE LA XUNTA DE GALICIA SA(R...
Reelecciones — 14/11/2012
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2612 , F 66, S 8, H C 4473, I/A 207 ( 2.11.12). 465318 - AUTOESTRADAS DE GALICIA AUTOPISTAS DE GALICIA CONCESIONARIA DE LA XUNTA DE GALICIA SA(R.M. A CORUÑA...
Página web de la sociedad — 23/07/2012
Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.audasa.es. Datos registrales. T 2612 , F 66, S 8, H C 4473, I/A 206 (13.07.12).
Reelecciones — 06/06/2012
Reelecciones. Miem.ComAyR.: ARECIBO SERVICIOS Y GESTIONES SL;LENCE MORENO RICARDO. P.Com.AyR: PUELLES GALLO JOSE. Miem.ComAyR.: PUELLES GALLO JOSE. Datos registrales. T 2612 , F 66, S 8, H C 4473, I/A 205 (28.05.12).
Revocaciones — 20/03/2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MUNTANER PEDROSA ANDRES;PILLADO MOSQUERA MARIA;CRIADO GONZALEZ MARCELINO;PEREZ GRACIA FRANCISCO JAVIER;PUELLES GALLO JOSE;LENCE MORENO RICARDO;DIAZ PEÑA JOSE ALBERTO;LOPEZ VERDEJO JUAN CARLOS...
Otros conceptos: escrito remitido por el registro mercantil de bilbaoen el que comunica el depósito de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2 — 30/11/2011
Otros conceptos: Escrito remitido por el Registro Mercantil de Bilbaoen el que comunica el depósito de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.010, el cual se archiva en el legajo 2º Bcon el número 163.- Dat...
Modificaciones estatutarias — 29/07/2011
Modificaciones estatutarias. 1. Denominación.-. 8. Acciones/Participaciones.-. 11. Acciones/Participaciones.-. 14. Comunicación al delegado del gobierno.-.Artículo 15º. Emisión de obligaciones.. 21. Funcionamiento Junta...
Nombramientos — 09/03/2011
Nombramientos. Apoderado: CESPEDOSA GONZALEZ MANUEL. Datos registrales. T 2612 , F 61, S 8, H C 4473, I/A 199 (28.02.11).
Ceses/dimisiones — 03/05/2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANDUEZA RETEGUI FIDEL. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ ORTIZ ALBERTO. Datos registrales. T 2612 , F 61, S 8, H C 4473, I/A 197 (23.04.10).
Ceses/dimisiones — 21/01/2010
Ceses/Dimisiones. Miem.ComAyR.: ENAITINERE SL. P.Com.AyR: ENAITINERE SL. Nombramientos. P.Com.AyR: PUELLES GALLO JOSE. Miem.ComAyR.: PUELLES GALLO JOSE. Reelecciones. Miem.ComAyR.: LENCE MORENO RICARDO. Datos registrale...
Ceses/dimisiones — 10/12/2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEAR ACQUISITION CORPORATION SL. Nombramientos. Consejero: ARECIBO SERVICIOS Y GESTIONES SL. Miem.ComAyR.: ARECIBO SERVICIOS Y GESTIONES SL. Datos registrales. T 2612 , F 60, S 8, H C 4473,...
Nombramientos — 10/12/2009
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2612 , F 61, S 8, H C 4473, I/A 195 ( 1.12.09).
Revocaciones — 02/11/2009
Revocaciones. Apoderado: SANZ BRAVO JUAN MARIA. Nombramientos. Apoderado: SANZ BRAVO JUAN MARIA. Datos registrales. T 2612 , F 59, S 8, H C 4473, I/A 193 (22.10.09).
Ceses/dimisiones — 04/09/2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA. Con.Delegado: ORIHUELA UZAL JOSE MARIA. Consejero: MIJANGOS GOROZARRI CARLOS;DEL RIVERO ASENSIO LUIS FERNANDO. Presidente: DEL RIVERO ASENSIO LUIS FERNANDO. Secreta...
Revocaciones — 04/09/2009
Revocaciones. Apoderado: SANZ BRAVO JUAN MARIA;REY SARMIENTO MANUEL. Apo.Man.Soli: ORTI BORDAS JOSE MIGUEL;MUNTANER PEDROSA ANDRES;PILLADO MOSQUERA MARIA;CRIADO GONZALEZ MARCELINO;DIAZ PEÑA ALBERTO;DIAZ PEÑA ALBERTO;MUN...