Actos destacados
Cancelaciones de oficio de nombramientos — 12/02/2016
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: AUDITGAL SA. Nombramientos. Auditor: AUDITGAL SA. Datos registrales. T 465 , F 142, S 8, H LU 577, I/A 49 ( 3.02.16).
Ampliación de capital — 09/03/2015
Ampliación de capital. Suscrito: 9.720,00 Euros. Desembolsado: 9.720,00 Euros. Resultante Suscrito: 69.720,00 Euros. Resultante Desembolsado: 69.720,00 Euros. Datos registrales. T 465 , F 141, S 8, H LU 577, I/A 48 (26....
Nombramientos — 17/11/2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CHICO LORCA CRISTINA;REDONDO FERNANDEZ JUAN JAVIER;SANTOS SANMARTIN SANDRA MARIA;GONZALEZ PEREIRA GENOVEVA;LOMBARDERO ALVAREZ OVIDIO. Datos registrales. T 465 , F 141, S 8, H LU 577, I/A 47...
Ceses/dimisiones — 30/06/2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ LOPEZ JOSE LUIS. Presidente: SANCHEZ LOPEZ JOSE LUIS. Consejero: SANTOS SANMARTIN SANDRA MARIA. Secretario: SANTOS SANMARTIN SANDRA MARIA. Consejero: FREIRE SANCHEZ MARIA REINA. Nomb...
Revocaciones — 30/06/2014
Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ LOPEZ JOSE LUIS;DIAZ SOUTO MANUEL DOMINGO. Apo.Man.Soli: QUINTAS GONZALEZ VICENTE;SANTOS SANMARTIN SANDRA MARIA;DIAZ LATORRE PALOMA;DIAZ LATORRE MANUEL DOMINGO;REDONDO FERNANDEZ JUAN JAVI...
Ceses/dimisiones — 19/08/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ LOPEZ JOSE LUIS. Presidente: SANCHEZ LOPEZ JOSE LUIS. Consejero: SANTOS SANMARTIN SANDRA MARIA. Secretario: SANTOS SANMARTIN SANDRA MARIA. Consejero: FREIRE SANCHEZ MARIA REINA;QUINT...
Reducción de capital — 04/07/2013
Reducción de capital. Importe reducción: 1.401.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 60.000,00 Euros. Desembolsado: 60.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Result...
Cancelaciones de oficio de nombramientos — 14/05/2013
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: TECNICOS AUDITORES CORUÑESES SL. Nombramientos. Auditor: AUDITGAL SA. Datos registrales. T 435 , F 31, S 8, H LU 577, I/A 42 ( 3.05.13).
Reelecciones — 20/01/2012
Reelecciones. Auditor: TECNICOS AUDITORES CORUÑESES SL. Datos registrales. T 435 , F 31, S 8, H LU 577, I/A 41 ( 9.01.12). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Ceses/dimisiones — 11/11/2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: QUINTAS GONZALEZ VICENTE. Presidente: QUINTAS GONZALEZ VICENTE. Consejero: DIAZ GONZALEZ JESUS. Vicepresid.: DIAZ GONZALEZ JESUS. Consejero: CASTRO TEIJEIRO ENRIQUE MANUEL;EDUARDO LAMAS GOME...
Revocaciones — 11/11/2011
Revocaciones. Apo.Sol.: DIAZ SOUTO MANUEL DOMINGO;DIAZ GONZALEZ JESUS;QUINTAS GONZALEZ VICENTE. BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 214 Viernes 11 de noviembre de 2011 Pág. 63752 cve: BORME-A-2011-214-27 Nombram...
Modificaciones estatutarias — 11/05/2011
Modificaciones estatutarias. En cuanto al plazo de desembolso.. Datos registrales. T 293 , F 163, S 8, H LU 577, I/A 38 (19.04.11).
Reelecciones — 03/02/2010
Reelecciones. Auditor: TECNICOS AUDITORES CORUÑESES SL. Datos registrales. T 293 , F 163, S 8, H LU 577, I/A 36 (20.01.10).
Reelecciones — 08/07/2009
Reelecciones. Consejero: QUINTAS GONZALEZ VICENTE. Presidente: QUINTAS GONZALEZ VICENTE. Consejero: DIAZ GONZALEZ JESUS. Vicepresid.: DIAZ GONZALEZ JESUS. Consejero: CASTRO TEIJEIRO ENRIQUE MANUEL;EDUARDO LAMAS GOMEZ. S...