Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 5 tarjetas
31/10/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Gipuzkoa
Gipuzkoa-452184

Ceses/dimisiones — 31/10/2019

Ceses/Dimisiones. Consejero: COUSILLAS JIMENEZ JOSE FERNANDO;GRACIA MAZA CARLOS JESUS;LECETA GRACIA ANA MARIA;PARRA RODRIGUEZ MAXIMO. Secretario: GRACIA MAZA CARLOS JESUS. Presidente: PARRA RODRIGUEZ MAXIMO. Nombramient...

21/12/2018 Sec. I Reducción de capital Gipuzkoa
Gipuzkoa-512262

Reducción de capital — 21/12/2018

Reducción de capital. Importe reducción: 107.611,22 Euros. Resultante Suscrito: 191.392,30 Euros. Datos registrales. T 1209 , F 186, S 8, H SS 4101, I/A 18 (10.12.18).

10/03/2016 Sec. I Nombramientos Gipuzkoa
Gipuzkoa-113031

Nombramientos — 10/03/2016

Nombramientos. Apoderado: GRACIA MAZA CARLOS JESUS;PARRA CALDERON NICOLAS. Datos registrales. T 1209 , F 184, S 8, H SS 4101, I/A 17 (29.02.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 48 Jueves 10 de marzo de 2016...

20/11/2014 Sec. I Reelecciones Gipuzkoa
Gipuzkoa-473322

Reelecciones — 20/11/2014

Reelecciones. Consejero: GRACIA MAZA CARLOS JESUS;COUSILLAS JIMENEZ JOSE FERNANDO;PARRA RODRIGUEZ MAXIMO.Presidente: PARRA RODRIGUEZ MAXIMO. Secretario: GRACIA MAZA CARLOS JESUS. Datos registrales. T 1209 , F 184, S 8,...

14/12/2009 Sec. I Nombramientos Gipuzkoa
Gipuzkoa-519048

Nombramientos — 14/12/2009

Nombramientos. Apoderado: TORRECILLA ARROSPIDE PEDRO. Datos registrales. T 1209 , F 183, S 8, H SS 4101, I/A 15 ( 2.12.09).