Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 7 tarjetas
19/03/2019 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-124643

Revocaciones — 19/03/2019

Revocaciones. Apoderado: BARROSO FELTRER MANUEL;GONZALEZ SANZ FERMIN;MARQUIEGUI CANDELAS FRANCISCO;BARROSO FELTRER MANUEL;GONZALEZ SANZ FERMIN;SAGUAR FERNANDEZ JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: SAGUAR FERNANDEZ JOSE LUIS;FERNAND...

20/02/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-79092

Ceses/dimisiones — 20/02/2019

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN MANERO ALFREDO. Datos registrales. T 31098 , F 203, S 8, H M 67638, I/A 35 (13.02.19).

11/12/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-494755

Revocaciones — 11/12/2018

Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ SANZ FERMIN;SAGUAR FERNANDEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAGUAR FERNANDEZ JOSE LUIS;FERNANDEZ DE VILLALOBOS MIGUEL ANGEL. Apo.Sol.: FERNANDEZ DE VILLALOBOS MIGUEL ANGEL. Dat...

08/08/2016 Sec. I Reducción de capital Madrid
Madrid-326568

Reducción de capital — 08/08/2016

Reducción de capital. Importe reducción: 97.727,59 Euros. Resultante Suscrito: 1.107.241,61 Euros. Datos registrales. T 31098 , F 201, S 8, H M 67638, I/A 33 (29.07.16).

04/08/2016 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-323222

Ampliación de capital — 04/08/2016

Ampliación de capital. Capital: 240.993,87 Euros. Resultante Suscrito: 1.204.969,20 Euros. Datos registrales. T 31098 , F 200, S 8, H M 67638, I/A 32 (27.07.16).

22/03/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-132132

Nombramientos — 22/03/2016

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SANZ FERMIN;SAGUAR FERNANDEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 31098 , F 200, S 8, H M 67638, I/A 31 (15.03.16).

11/06/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-233000

Ceses/dimisiones — 11/06/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: BARROSO FERNANDEZ DE ARAOZ SOFIA. Vicepresid.: BARROSO FERNANDEZ DE ARAOZ SOFIA. Nombramientos. Vicepresid.: BARROSO FERNANDEZ DE ARAOZ MARIA PAZ. Otros conceptos: HA QUEDADO MODIFICADO EL A...