Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 13 tarjetas
17/12/2018 Sec. I Situación concursal Madrid
Madrid-502530

Situación concursal — 17/12/2018

Situación concursal. Procedimiento concursal 1081/2018. FIRME: No, Fecha de resolución 13/11/2018. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID. Juez: OLGA MAR...

27/07/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-313222

Revocaciones — 27/07/2018

Revocaciones. Apoderado: VALERO QUIROS JUAN CARLOS. Datos registrales. T 31130 , F 86, S 8, H M 133581, I/A 61 (20.07.18).

16/07/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-293832

Ceses/dimisiones — 16/07/2018

Ceses/Dimisiones. Presidente: HERNANDEZ DURAN CONSTANTINO. Secretario: VALERO QUIROS JUAN CARLOS. Consejero: HERNANDEZ DURAN CONSTANTINO. Con.Delegado: HERNANDEZ DURAN CONSTANTINO. Consejero: MAIER ALLENDE CARLOS;VEGA W...

17/04/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-167861

Revocaciones — 17/04/2018

Revocaciones. Apoderado: VERA ZAMBRANA ANTONIO;ALGUACIL AMORES RAFAEL. Nombramientos. Apoderado: NUÑEZ PARRADO RUBEN. Datos registrales. T 31130 , F 84, S 8, H M 133581, I/A 59 (10.04.18).

27/07/2017 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-309227

Ampliación de capital — 27/07/2017

Ampliación de capital. Suscrito: 612.839,70 Euros. Desembolsado: 612.839,70 Euros. Resultante Suscrito: 1.843.267,00 Euros. Resultante Desembolsado: 1.843.267,00 Euros. Datos registrales. T 31130 , F 81, S 8, H M 133581...

20/04/2017 Sec. I Página web de la sociedad Madrid
Madrid-171948

Página web de la sociedad — 20/04/2017

Página web de la sociedad. Modificación de la página web corporativa.Nueva página web: www.intropia.com. Datos registrales. T 31130 , F 81, S 8, H M 133581, I/A 54 (11.04.17).

25/01/2017 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-38968

Reelecciones — 25/01/2017

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 31130 , F 81, S 8, H M 133581, I/A 53 (17.01.17).

14/12/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-505940

Revocaciones — 14/12/2016

Revocaciones. Apoderado: DE SALVADOR Y ARANA DIEGO. Nombramientos. Apoderado: SUAREZ CANTON PEÑA NICOLAS RAFAEL. Datos registrales. T 31130 , F 80, S 8, H M 133581, I/A 52 ( 2.12.16).

22/05/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-207807

Nombramientos — 22/05/2015

Nombramientos. Apoderado: GARCIA FERNANDEZ CRISTINA. Datos registrales. T 31130 , F 80, S 8, H M 133581, I/A 50 (12.05.15).

17/02/2015 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-70353

Reelecciones — 17/02/2015

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 31130 , F 79, S 8, H M 133581, I/A 47 ( 9.02.15).

26/06/2014 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-266007

Revocaciones — 26/06/2014

Revocaciones. Apoderado: ABITBOL OEVERMANN RAFAEL. Datos registrales. T 31130 , F 79, S 8, H M 133581, I/A 46 (16.06.14).

27/08/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-377757

Ceses/dimisiones — 27/08/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ DURAN CONSTANTINO;MAIER ALLENDE CARLOS;VEGA WERLER EDUARDO;ABITBOL OEVERMANN RAFAEL;BERGEL SAINZ DE BARANDA JAIME ISIDORO;VALERO QUIROS JUAN CARLOS. Presidente: HERNANDEZ DURAN CON...

25/11/2010 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-436641

Reelecciones — 25/11/2010

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 17436 , F 139, S 8, H M 133581, I/A 39 (15.11.10).