Actos destacados
Modificaciones estatutarias — 20/12/2019
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-. Cambio de domicilio social. C/ METALURGICOS 14B - PARQUE EMRPESARIAL PRINCIPAD (AVILES). Datos registrales. T 3842 , F 172...
Ceses/dimisiones — 20/02/2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: INVERBLYP SL;DIAZ GARCIA AVELINO;GARCIA FERNANDEZ PEDRO. Presidente: INVERBLYP SL. Secretario: DIAZ GARCIA AVELINO. Con.Delegado: INVERBLYP SL. Nombramientos. Consejero: INVERBLYP SL;DIAZ GA...
Reelecciones — 18/12/2018
Reelecciones. Auditor: VERSUS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 3842 , F 167, S 8, H AS 2582, I/A 31 (10.12.18).
Revocaciones — 20/06/2017
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ CANAL CARLOS IGNACIO. Nombramientos. Apo.Sol.: SOLDEVILLA RUBIERA NICOLAS. Datos registrales. T 3842 , F 167, S 8, H AS 2582, I/A 30 (12.06.17).
Revocaciones — 16/12/2016
Revocaciones. Apo.Sol.: DE LA ROSA TASCON CRISTINA. Datos registrales. T 3842 , F 167, S 8, H AS 2582, I/A 29 ( 2.12.16).
Reelecciones — 23/08/2016
Reelecciones. Auditor: VERSUS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 3842 , F 166, S 8, H AS 2582, I/A 28 (12.08.16).
Revocaciones — 18/12/2015
Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ FUENTES MARIA JESUS. Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ CANAL CARLOS IGNACIO. Datos registrales. T 3842 , F 166, S 8, H AS 2582, I/A 27 (10.12.15).
Fusión por absorción — 08/09/2015
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: ASTURMATIC SYSTEMS SA. Datos registrales. T 3842 , F 166, S 8, H AS 2582, I/A 26 (31.08.15).
Revocaciones — 26/03/2015
Revocaciones. Con.Delegado: INVERBLYP SL. Reelecciones. Consejero: INVERBLYP SL;DIAZ GARCIA AVELINO;GARCIA FERNANDEZ PEDRO. Datos registrales. T 3842 , F 165, S 8, H AS 2582, I/A 24 (18.03.15).
Nombramientos — 26/03/2015
Nombramientos. Con.Delegado: INVERBLYP SL. Reelecciones. Presidente: INVERBLYP SL. Secretario: DIAZ GARCIA AVELINO. Datos registrales. T 3842 , F 165, S 8, H AS 2582, I/A 25 (18.03.15).
Declaración de unipersonalidad — 30/06/2014
Declaración de unipersonalidad. Socio único: INVERBLYP SL. Datos registrales. T 3842 , F 165, S 8, H AS 2582, I/A 23 (23.06.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 121 Lunes 30 de junio de 2014 Pág. 29369 cve:...
Nombramientos — 10/06/2014
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA MENENDEZ MARCOS. Datos registrales. T 3668 , F 210, S 8, H AS 2582, I/A 15 (27.09.10).
Revocaciones — 10/06/2014
Revocaciones. Apo.Sol.: SOLDEVILLA RUBIERA NICOLAS;DIAZ GARCIA AVELINO;GARCIA MENENDEZ MARCOS. Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ FUENTES MARIA JESUS;DIAZ GARCIA AVELINO;GARCIA MENENDEZ MARCOS. Apo.Manc.: DIAZ GARCIA AV...
Reelecciones — 04/03/2014
Reelecciones. Auditor: VERSUS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 3842 , F 164, S 8, H AS 2582, I/A 21 (19.02.14).
Ceses/dimisiones — 12/09/2012
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: VALLAURE FERNANDEZ ALFONSO JESUS. Vicesecret.: RUIBALDEFLORES ALVAREZ MANUEL. Nombramientos. Secretario: DIAZ GARCIA AVELINO. Datos registrales. T 3842 , F 164, S 8, H AS 2582, I/A 19 (30...
Nombramientos — 15/11/2010
Nombramientos. Aud.Supl.: SUAREZ GOMEZ JUAN LUIS. Reelecciones. Auditor: FERNANDEZ VIAR MANUEL. Datos registrales. T 3842 , F 164, S 8, H AS 2582, I/A 17 ( 2.11.10).
Nombramientos — 15/11/2010
Nombramientos. Auditor: VERSUS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 3842 , F 164, S 8, H AS 2582, I/A 18 ( 2.11.10).
Nombramientos — 08/10/2010
Nombramientos. Apo.Sol.: SOLDEVILLA RUBIERA NICOLAS;DIAZ GARCIA AVELINO;DE LA ROSA TASCON CRISTINA;GARCIA MENENDEZ MARCOS. Datos registrales. T 3668 , F 210, S 8, H AS 2582, I/A 15 (27.09.10).