Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 6 tarjetas
15/06/2015 Sec. I Ampliación de capital Pontevedra
Pontevedra-241364

Ampliación de capital — 15/06/2015

Ampliación de capital. Capital: 425.700,00 Euros. Resultante Suscrito: 429.000,00 Euros. Datos registrales. T 2660, L 2660, F 73, S 8, H PO 29109, I/A 16 ( 5.06.15).

10/07/2014 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-285191

Revocaciones — 10/07/2014

Revocaciones. Apoderado: MENDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN. Apo.Manc.: CABRAL COSTAS MARIA TERESA;PEREZ FIGUEROA BEATRIZ;PRIETO DO REGO RUTH. Datos registrales. T 2660, L 2660, F 73, S 8, H PO 29109, I/A 15 ( 3.07.14). http...

13/11/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Pontevedra
Pontevedra-464390

Ceses/dimisiones — 13/11/2012

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MENDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. Adm. Unico: DO REGO FERNANDEZ ROBERTO. Ampliacion del objeto social. Arrendamiento de todo tipo de bienes inmuebles. Datos registrales. T 2660,...

13/11/2012 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-464391

Revocaciones — 13/11/2012

Revocaciones. Apo.Manc.: CABRAL COSTAS MARIA TERESA;PRIETO DO REGO RUTH. Nombramientos. Apo.Manc.: CABRAL COSTAS MARIA TERESA;PRIETO DO REGO RUTH. Datos registrales. T 2660, L 2660, F 73, S 8, H PO 29109, I/A 14 (31.10....

06/05/2011 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-195466

Revocaciones — 06/05/2011

Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ BARREIRA MANUEL;PEREZ FIGUEROA BEATRIZ. Nombramientos. Apo.Manc.: PRIETO BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 86 Viernes 6 de mayo de 2011 Pág. 23366 cve: BORME-A-2011-86-36 DO R...

15/09/2010 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-352111

Revocaciones — 15/09/2010

Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ CABALEIRO JOSE-MANUEL. Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ BARREIRA MANUEL;PEREZ FIGUEROA BEATRIZ. Datos registrales. T 2660, L 2660, F 71, S 8, H PO 29109, I/A 11 ( 6.09.10).