Actos destacados
Disolución — 26/12/2019
Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 721, L 512, F 218, S 8, H BU 13686, I/A 27 (18.12.19).
Revocaciones — 26/02/2019
Revocaciones. Apo.Sol.: CASAÑ GIL DAVID. Nombramientos. Apo.Sol.: ZAPATA LOZANO ROBERTO. Datos registrales. T 721, L 512, F 217, S 8, H BU 13686, I/A 26 (20.02.19).
Revocaciones — 03/01/2019
Revocaciones. Apo.Sol.: ARANO ECHEBARRIA JOSEBA;CARNERO FERNANDEZ JESUS. Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALO DIAZ CRISTINA;URCELAY IGARTUA LUCIA;MARTIN GONZALEZ EMILIO;ESPINOSA SALAZAR ANTONIO. Datos registrales. T 721, L...
Reelecciones — 21/12/2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 721, L 512, F 217, S 8, H BU 13686, I/A 24 (14.12.18). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 244 Viernes 21 de diciembre de 2018 Pág...
Sociedad unipersonal — 16/01/2018
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: CALIDAD PASCUAL SA. Datos registrales. T 721, L 512, F 216, S 8, H BU 13686, I/A 23 (10.01.18).
Reelecciones — 27/12/2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 695, L 486, F 193, S 8, H BU 13686, I/A 22 (19.12.17).
Reelecciones — 14/02/2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 695, L 486, F 193, S 8, H BU 13686, I/A 21 ( 7.02.17).
Revocaciones — 21/12/2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BOTIN MARTIN-BARBADILLO CARLOS;GARRIDO SAINZ RUBEN;GARCIA ALVARO CARMELO;VICENTE GIL LORENZO;SAIZ RAMIREZ JOSE LUIS. Apo.Sol.: DE LA CALLE ARMESTO DAVID. Apo.Man.Soli: MARTIN GONZALEZ EMILIO;...
Ceses/dimisiones — 25/10/2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: PASCUAL GOMEZ CUETARA TOMAS FLORENCIO;PASCUAL GOMEZ CUETARA SONIA;PASCUAL GOMEZ CUETARA MARIA DEL PILAR;PASCUAL GOMEZ CUETARA FRANCISCO BORJA. Presidente: PASCUAL GOMEZ CUETARA TOMAS FLORENC...
Revocaciones — 20/07/2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: COLOMINA PEREZ DEL RIO JAVIER;BOTIN MARTIN-BARBADILLO CARLOS;GARRIDO SAINZ RUBEN;GARCIA ALVARO CARMELO;VICENTE GIL LORENZO;GARCIA-CANO SALGADO IGNACIO. Apo.Sol.: DE LA CALLE ARMESTO DAVID. Ap...
Reelecciones — 25/01/2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 695, L 486, F 189, S 8, H BU 13686, I/A 17 (19.01.16).
Otros conceptos: modificación de estatutos sociales de la sociedad, con el objeto de adaptarlos a las modificaciones introducidas en la ley de sociedades de capital por la ley 31/2014 de 3 de diciembre — 26/10/2015
Otros conceptos: Modificación de Estatutos Sociales de la sociedad, con el objeto de adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre. Ampliacion del o...
Reelecciones — 19/01/2015
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 650, L 441, F 58, S 8, H BU 13686, I/A 15 (13.01.15).
Ceses/dimisiones — 12/08/2014
Ceses/Dimisiones. Secretario: PASCUAL GOMEZ CUETARA SONIA. Vicepresid.: PASCUAL GOMEZ CUETARA FRANCISCO BORJA. Nombramientos. Secretario: PASCUAL GOMEZ CUETARA FRANCISCO BORJA. Datos registrales. T 650, L 441, F 58, S 8...
Reelecciones — 24/12/2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 650, L 441, F 58, S 8, H BU 13686, I/A 13 (17.12.13).
Ceses/dimisiones — 04/07/2012
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PASCUAL GOMEZ CUETARA TOMAS FLORENCIO. Nombramientos. Apoderado: PASCUAL GOMEZ CUETARA TOMAS FLORENCIO. Datos registrales. T 650, L 441, F 57, S 8, H BU 13686, I/A 12 (25.06.12).
Nombramientos — 18/06/2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: COLOMINA PEREZ DEL RIO JAVIER;BOTIN MARTIN-BARBADILLO CARLOS;GARRIDO SAINZ RUBEN;GARCIA ALVARO CARMELO;VICENTE GIL LORENZO;GARCIA-CANO SALGADO IGNACIO. Apo.Sol.: DE LA CALLE ARMESTO DAVID. A...
Revocaciones — 18/06/2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: COLOMINA PEREZ DEL RIO JAVIER;BOTIN MARTIN-BARBADILLO CARLOS;GORRIZ MORENO FRANCISCO;CASTAÑEDA CAMARERO ANTONIO;CASTILLA COBO ANTONIO;RODRIGUEZ ALONSO OCTAVIO;GARRIDO SAINZ RUBEN;GARCIA ALVAR...
Nombramientos — 17/06/2011
Nombramientos. Apo.Sol.: ARANO ECHEBARRIA JOSEBA;CARNERO FERNANDEZ JESUS. Datos registrales. T 626, L 417, F 217, S 8, H BU 13686, I/A 9 ( 9.06.11).
Ampliación de capital — 05/05/2011
Ampliación de capital. Capital: 840.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 984.429,00 Euros. Datos registrales. T 626, L 417, F 215, S 8, H BU 13686, I/A 8 (25.04.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 85 Jueves 5...
Fe de erratas: por diligencia incorporada a la escritura que causó la inscripción 3&, se rectifica el dni del apoderado don antonio castilla cobo, siendo el correcto 13 — 04/04/2011
Fe de erratas: Por diligencia incorporada a la escritura que causó la inscripción 3&, se rectifica el DNI del apoderado DON ANTONIO CASTILLA COBO, siendo el correcto 13.066.751-Z. Datos registrales. T 626, L 417, F 215,...
Nombramientos — 04/02/2011
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 624, L 415, F 170, S 8, H BU 13686, I/A 6 (26.01.11).
Sociedad unipersonal — 26/01/2011
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: CORPORACION EMPRESARIAL PASCUAL S.L. Datos registrales. T 624, L 415, F 170, S 8, H BU 13686, I/A 5 (17.01.11).
Ampliación de capital — 28/09/2010
Ampliación de capital. Capital: 141.329,00 Euros. Resultante Suscrito: 144.429,00 Euros. Datos registrales. T 622, L 413, F 19, S 8, H BU 13686, I/A 4 (17.09.10).