Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 7 tarjetas
27/12/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-542249

Ceses/dimisiones — 27/12/2019

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ARTAL MARTELES LUIS ALBERTO. Nombramientos. Adm. Unico: CENTRO MULTIMARCA ZARAGOZA SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 2033 , F 137, S 8, H Z 6907, I/A 16 (19.12.19).

27/12/2019 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-542250

Revocaciones — 27/12/2019

Revocaciones. Apoderado: ARTAL MARTELES FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 4292 , F 84, S 8, H Z 6907, I/A 17 (19.12.19).

18/03/2016 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-127719

Revocaciones — 18/03/2016

Revocaciones. Apo.Man.Soli: BOLEA ESCARTIN MAXIMO;COZAR DELGADO RAFAEL;LECIÑENA SANCHO MARIA SANCHO ABARCA. Datos registrales. T 2033 , F 136, S 8, H Z 6907, I/A 15 (11.03.16).

29/08/2013 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-381973

Nombramientos — 29/08/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: ARTAL MARTELES FRANCISCO JOSE;ARTAL MARTELES JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 2033 , F 136, S 8, H Z 6907, I/A 14 (21.08.13).

24/06/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-287876

Ceses/dimisiones — 24/06/2013

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ARTAL MARTLES JUAN CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: ARTAL MARTELES LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 2033 , F 136, S 8, H Z 6907, I/A 13 (13.06.13).

08/02/2012 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-64403

Revocaciones — 08/02/2012

Revocaciones. Auditor: AUREN AUDITORES ZAZ SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 2033 , F 136, S 8, H Z 6907, I/A 12 (26.01.12).

02/01/2012 Sec. I Ampliación de capital Zaragoza
Zaragoza-3170

Ampliación de capital — 02/01/2012

Ampliación de capital. Capital: 232.647,10 Euros. Resultante Suscrito: 340.827,10 Euros. Datos registrales. T 2033 , F 136, S 8, H Z 6907, I/A 11 (22.12.11).