Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2013 15 tarjetas
18/10/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-447159

Nombramientos — 18/10/2013

Nombramientos. Apoderado: MONJE GUTIERREZ SUSANA. Datos registrales. T 21189 , F 224, S 8, H M 376288, I/A 16 ( 8.10.13).

22/08/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-350777

Nombramientos — 22/08/2012

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ YUSTE JUAN;BIGORRA PAEZ JOSEP MARIA;ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 21189 , F 222, S 8, H M 376288, I/A 14 ( 9.08.12).

22/08/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-350778

Revocaciones — 22/08/2012

Revocaciones. Apo.Sol.: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Apo.Manc.: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Datos registrales. T 21189 , F 224, S 8, H M 376288, I/A 15 ( 9.08.12).

22/08/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-350777

Nombramientos — 22/08/2012

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ YUSTE JUAN;BIGORRA PAEZ JOSEP MARIA;ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 21189 , F 222, S 8, H M 376288, I/A 14 ( 9.08.12).

22/08/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-350778

Revocaciones — 22/08/2012

Revocaciones. Apo.Sol.: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Apo.Manc.: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Datos registrales. T 21189 , F 224, S 8, H M 376288, I/A 15 ( 9.08.12).

30/12/2010 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-486197

Nombramientos — 30/12/2010

Nombramientos. Apo.Sol.: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Apo.Manc.: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Apo.Sol.: ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 211...

30/12/2010 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-486197

Nombramientos — 30/12/2010

Nombramientos. Apo.Sol.: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Apo.Manc.: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Apo.Sol.: ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 211...

24/02/2010 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-79362

Nombramientos — 24/02/2010

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BIGORRA PAEZ JOSEP MARIA;ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 21189 , F 166, S 8, H M 376288, I/A 12 (15.02.10).

24/02/2010 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-79362

Nombramientos — 24/02/2010

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BIGORRA PAEZ JOSEP MARIA;ROCHA CARRETERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 21189 , F 166, S 8, H M 376288, I/A 12 (15.02.10).

16/12/2009 Sec. I Reducción de capital Madrid
Madrid-524197

Reducción de capital — 16/12/2009

Reducción de capital. Importe reducción: 3.884.296,64 Euros. Resultante Suscrito: 3.621.234,68 Euros. Datos registrales. T 21189 , F 165, S 8, H M 376288, I/A 11 ( 4.12.09).

16/12/2009 Sec. I Reducción de capital Madrid
Madrid-524197

Reducción de capital — 16/12/2009

Reducción de capital. Importe reducción: 3.884.296,64 Euros. Resultante Suscrito: 3.621.234,68 Euros. Datos registrales. T 21189 , F 165, S 8, H M 376288, I/A 11 ( 4.12.09).

18/03/2009 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-136716

Cambio de domicilio social — 18/03/2009

Cambio de domicilio social. AVDA QUITAPESARES 11 - P.E. VILLAPARK (VILLAVICIOSA DE ODON). Datos registrales. T 21189 , F 165, S 8, H M 376288, I/A 10 ( 9.03.09).

18/03/2009 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-136716

Cambio de domicilio social — 18/03/2009

Cambio de domicilio social. AVDA QUITAPESARES 11 - P.E. VILLAPARK (VILLAVICIOSA DE ODON). Datos registrales. T 21189 , F 165, S 8, H M 376288, I/A 10 ( 9.03.09).

13/01/2009 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-16598

Ampliación de capital — 13/01/2009

Ampliación de capital. Capital: 5.562.528,16 Euros. Resultante Suscrito: 7.505.531,32 Euros. Datos registrales. T 21189 , F 165, S 8, H M 376288, I/A 9 (30.12.08).

13/01/2009 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-16598

Ampliación de capital — 13/01/2009

Ampliación de capital. Capital: 5.562.528,16 Euros. Resultante Suscrito: 7.505.531,32 Euros. Datos registrales. T 21189 , F 165, S 8, H M 376288, I/A 9 (30.12.08).