Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 13 tarjetas
05/01/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-8578

Ceses/dimisiones — 05/01/2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Consejero: SALDAÑA OLIETE JOSE-MANUEL. Vicepresid.: SALDAÑA OLIETE JOSE-MANUEL. Consejero: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Secretario: FRA...

26/05/2017 Sec. I Declaración de unipersonalidad Zaragoza
Zaragoza-221214

Declaración de unipersonalidad — 26/05/2017

Declaración de unipersonalidad. Socio único: SOCIEDAD ANONIMA MINERA CATALANO-ARAGONESA-SAMCA- Datos registrales. T 3331 , F 197, S 8, H Z 802, I/A 40 (19.05.17).

24/03/2017 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-134244

Revocaciones — 24/03/2017

Revocaciones. Apoderado: LASHERAS SOBRINO CARLOS. Apo.Man.Soli: ARIÑO PERDIGUERO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3331 , F 196, S 8, H Z 802, I/A 39 (16.03.17). 134245 - AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA TERCER MILENIO MON...

23/11/2016 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-474963

Nombramientos — 23/11/2016

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ MORENO ADRIAN ANGEL. Datos registrales. T 3331 , F 195, S 8, H Z 802, I/A 38 (15.11.16).

10/02/2016 Sec. I Modificaciones estatutarias Zaragoza
Zaragoza-60760

Modificaciones estatutarias — 10/02/2016

Modificaciones estatutarias. Modificado el artículo 12º de los Estatutos Sociales, relativo al órgano de administración.. Modificado el artículo 14º de los Estatutos Sociales, relativo a la gratuidad del cargo de admini...

27/08/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-354017

Ceses/dimisiones — 27/08/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL;FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL;ORERA PEÑA JOSE RUBEN. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Vicepresid.: ORERA PEÑA JOSE RUBEN. Secretario: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Consejero:...

03/04/2014 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-150510

Revocaciones — 03/04/2014

Revocaciones. Apoderado: CLAVERIA CINTORA ANTONIO. Datos registrales. T 3331 , F 194, S 8, H Z 802, I/A 35 (25.03.14).

03/10/2013 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-424980

Nombramientos — 03/10/2013

Nombramientos. Apoderado: AINA MATEO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3331 , F 192, S 8, H Z 802, I/A 33 (24.09.13).

03/10/2013 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-424981

Nombramientos — 03/10/2013

Nombramientos. Apoderado: CLAVERIA CINTORA ANTONIO. Datos registrales. T 3331 , F 193, S 8, H Z 802, I/A 34 (24.09.13).

23/01/2013 Sec. I Ampliación de capital Zaragoza
Zaragoza-35002

Ampliación de capital — 23/01/2013

Ampliación de capital. Suscrito: 486.891,00 Euros. Desembolsado: 486.891,00 Euros. Resultante Suscrito: 547.001,00 Euros. Resultante Desembolsado: 547.001,00 Euros. Datos registrales. T 3331 , F 192, S 8, H Z 802, I/A 3...

12/03/2012 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-118927

Nombramientos — 12/03/2012

Nombramientos. Consejero: SALDAÑA OLIETE JOSE-MANUEL. Vicesecret.: SALDAÑA OLIETE JOSE-MANUEL. Cons.Del.Sol: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL;ORERA PEÑA JOSE RUBEN;SALDAÑA OLIETE JOSE-MANUEL. Reelecciones. Consejero: LUENGO MAR...

05/01/2011 Sec. I Modificaciones estatutarias Zaragoza
Zaragoza-5036

Modificaciones estatutarias — 05/01/2011

Modificaciones estatutarias. Artículo Decimosegundo.- La Administración de la Sociedad se confía al Consejo de Adminsitración, que estará integradopor tres miembros como mínimo y siete como máximo. Corresponde a la Junt...

29/06/2009 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-293596

Revocaciones — 29/06/2009

Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEDRAJAS GARCIA RICARDO. Apo.Manc.: PEDRAJAS GARCIA RICARDO. Apo.Man.Soli: BAÑOS ARTIEDA JORGE. Datos registrales. T 3331 , F 129, S 8, H Z 802, I/A 29 (18.06.09). http://www.boe.es BOLETÍN O...