Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 13 tarjetas
14/10/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-424685

Ceses/dimisiones — 14/10/2019

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AMERICAN RESTAURANTS SP ZOO. Representan: CHANDLER MARK RANDALL. Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ PICAZO RODRIGUEZ MARIA. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ-PICAZO RODRIGUEZ MARIA;CHIQUERO MIELGO VI...

13/08/2019 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-354581

Revocaciones — 13/08/2019

Revocaciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39110 , F 202, S 8, H M 513953, I/A 27 ( 6.08.19).

17/06/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-260955

Nombramientos — 17/06/2019

Nombramientos. Apoderado: GARCIA DEL VALLE FERNANDEZ SIMAL IGNACIO. Datos registrales. T 37473 , F 225, S 8, H M 513953, I/A 26 (10.06.19).

23/10/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-422565

Revocaciones — 23/10/2018

Revocaciones. Apo.Sol.: CHANDLER MARK RANDALL. Apoderado: CHANDLER MARK RANDALL;PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA;COLLADO RODRIGUEZ JESUS;JAÑEZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN;PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA;PATO- CASTEL TADEO MARI...

08/06/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-242503

Revocaciones — 08/06/2018

Revocaciones. Apo.Sol.: BOLINSKI PIOTR. Apoderado: BOLINSKI PIOTR. Apo.Manc.: BOLINSKI PIOTR. Apo.Man.Soli: BOLINSKI PIOTR. Nombramientos. Apoderado: PIECHNA KRZYSZTOF. Datos registrales. T 34508 , F 67, S 8, H M 513953...

15/01/2018 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-18749

Reelecciones — 15/01/2018

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 34508 , F 66, S 8, H M 513953, I/A 21 ( 2.01.18).

23/11/2016 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-474219

Reelecciones — 23/11/2016

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 34508 , F 66, S 8, H M 513953, I/A 20 (16.11.16).

08/02/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-55732

Nombramientos — 08/02/2016

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ PICAZO RODRIGUEZ MARIA. Datos registrales. T 28838 , F 221, S 8, H M 513953, I/A 17 ( 1.02.16).

09/12/2011 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-490093

Nombramientos — 09/12/2011

Nombramientos. Apoderado: WINEGAR STEVEN KENT;MCGOVERN HENRY JOSEPH;CHANDLER MARK RANDALL;BOLINSKI PIOTR;PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA;COLLADO RODRIGUEZ JESUS;MICHAVILA ESCRIBANO MARIA JOSE. Datos registrales. T 28838 ,...

24/05/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-221166

Ceses/dimisiones — 24/05/2011

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANTIAGO PEREZ ANTONIO. Nombramientos. VsecrNoConsj: SANCHEZ MONTALBAN JOSE. Consejero: KENT WINEGAR STEVEN. Presidente: KENT WINEGAR STEVEN. Consejero: BOLINSKI PIOTR;DE LA PEDRAJA ANGULO...

24/05/2011 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-221167

Modificaciones estatutarias — 24/05/2011

Modificaciones estatutarias. NUEVA REDACCION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 28548 , F 148, S 8, H M 513953, I/A 6 (12.05.11).

24/05/2011 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-221168

Nombramientos — 24/05/2011

Nombramientos. M.Com.Ej: BOLINSKI PIOTR;CHANDLER MARK RANDALL;KENT WINEGAR STEVEN. Datos registrales. T 28548 , F 151, S 8, H M 513953, I/A 7 (12.05.11).

20/05/2011 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-216824

Ampliación de capital — 20/05/2011

Ampliación de capital. Capital: 2.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.503.600,00 Euros. Datos registrales. T 28548 , F 147, S 8, H M 513953, I/A 4 (10.05.11).