Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2017 14 tarjetas
01/06/2017 Sec. I Otros conceptos: MEDIANTE CERTIFICACION DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017 EXPEDIDA POR EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA, SE HACE CONSTAR QUE LA SOCIEDAD "AMAYA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S Madrid
Madrid-228970

Otros conceptos: mediante certificacion de fecha 17 de mayo de 2017 expedida por el registro mercantil de barcelona, se hace constar que la sociedad "amaya compaÑia de seguros y reaseguros, s — 01/06/2017

Otros conceptos: MEDIANTE CERTIFICACION DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017 EXPEDIDA POR EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA, SE HACE CONSTAR QUE LA SOCIEDAD "AMAYA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A." HA SIDO ABSORBIDA POR "...

21/12/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-516458

Revocaciones — 21/12/2016

Revocaciones. Apoderado: DIAZ OLIVER JULIO CORRALES. Datos registrales. T 34590 , F 19, S 8, H M 84287, I/A 435 (13.12.16).

17/11/2016 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-465244

Modificaciones estatutarias — 17/11/2016

Modificaciones estatutarias. 1. Modificación de la redacción del artículo 1º de los estatutos sociales.- . Ampliacion del objeto social. La Sociedad tiene por objeto desarrollar su actividad, en todo el- territorio espa...

09/09/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-371019

Revocaciones — 09/09/2016

Revocaciones. Apoderado: CANO SANTANA BEATRIZ. Datos registrales. T 34590 , F 18, S 8, H M 84287, I/A 432 ( 2.09.16).

09/09/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-371020

Revocaciones — 09/09/2016

Revocaciones. Apoderado: MACHO MARTIN LUCIA. Datos registrales. T 34590 , F 18, S 8, H M 84287, I/A 433 ( 2.09.16).

21/03/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-129376

Nombramientos — 21/03/2016

Nombramientos. Apoderado: FERRE ARLANDEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 18925 , F 74, S 8, H M 84287, I/A 425 (10.03.16).

10/07/2015 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-284022

Modificaciones estatutarias — 10/07/2015

Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 1, 3, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 26, 29 Y 30 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 18925 , F 72, S 8, H M 84287, I/A 422 ( 2.07.15).

09/07/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-282135

Ceses/dimisiones — 09/07/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: PUIG GARCIA MARTA;MARTI ARNAU LORENA. Nombramientos. Consejero: NAVARRO GARCIA OSCAR ROQUE;FERNANDEZ NIÑO EMILIO. Datos registrales. T 18925 , F 72, S 8, H M 84287, I/A 421 ( 2.07.15).

30/07/2014 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-313613

Reelecciones — 30/07/2014

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 18925 , F 67, S 8, H M 84287, I/A 416 (23.07.14).

20/11/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-495485

Revocaciones — 20/11/2013

Revocaciones. Apoderado: PEÑA CASTELLET LUZ;BUSTO HERRANZ JUAN MIGUEL;GOMEZ MONEDERO DEL VAL MARIA PALOMA;MILLAN LOPEZ JOSE. Apo.Manc.: MILLAN LOPEZ JOSE. Apo.Man.Soli: CALVO MAÑA MARIA TERESA;VALENZUELA PULIDO JOAQUIN....

17/09/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-379611

Nombramientos — 17/09/2012

Nombramientos. Apo.Man.Soli: AMA REDONDO CRISTINA DEL. Datos registrales. T 18925 , F 47, S 8, H M 84287, I/A 397 ( 4.09.12).

17/09/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-379612

Nombramientos — 17/09/2012

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SUBIRA AMOROS GISELA. Datos registrales. T 18925 , F 48, S 8, H M 84287, I/A 398 ( 4.09.12).

16/07/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-280859

Ceses/dimisiones — 16/07/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARELLI PAOLO. Presidente: MARELLI PAOLO. Nombramientos. Consejero: SALES OLLE JOSEP MARIA. Presidente: SALES OLLE JOSEP MARIA. Datos registrales. T 18925 , F 43, S 8, H M 84287, I/A 386 ( 6...

29/07/2009 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-334961

Reelecciones — 29/07/2009

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 18925 , F 41, S 8, H M 84287, I/A 379 (16.07.09).