Actos destacados
Transformación de sociedad — 28/12/2016
Transformación de sociedad. Denominación y forma adoptada: ALUMINIOS NERVION SL. Reelecciones. Adm. Solid.: GOMEZ BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 245 Miércoles 28 de diciembre de 2016 Pág. 56750 cve: BORME-A...
Reelecciones — 08/02/2016
Reelecciones. Aud.C.Con.: CONAUDIRE SLP. Datos registrales. T 472, L 263, F 62, S 8, H BU 1154, I/A 24 ( 2.02.16).
Reducción de capital — 09/12/2015
Reducción de capital. Importe reducción: 45.075,00 Euros. Resultante Suscrito: 255.425,00 Euros. Datos registrales. T 472, L 263, F 62, S 8, H BU 1154, I/A 23 ( 1.12.15).
Reelecciones — 15/10/2013
Reelecciones. Aud.C.Con.: CONAUDIRE SLP. Datos registrales. T 472, L 263, F 62, S 8, H BU 1154, I/A 22 ( 8.10.13).
Nombramientos — 27/08/2013
Nombramientos. Apoderado: SANMARTIN VAZQUEZ ANTONIO. Datos registrales. T 472, L 263, F 61, S 8, H BU 1154, I/A 21 (20.08.13).
Nombramientos — 10/07/2013
Nombramientos. Apoderado: GABARRON COMAS JESUS. Datos registrales. T 472, L 263, F 61, S 8, H BU 1154, I/A 20 ( 4.07.13).
Reelecciones — 05/12/2011
Reelecciones. Adm. Solid.: GOMEZ ALONSO JOSE MARIA;RUIZ ARROYO ROSA MARIA. Datos registrales. T 472, L 263, F 61, S 8, H BU 1154, I/A 19 (24.11.11).
Ceses/dimisiones — 25/11/2011
Ceses/Dimisiones. Aud.C.Con.: CONSULTOR OFFICE ZARAGOZA SL. Nombramientos. Aud.C.Con.: CONAUDIRE SLP. Datos registrales. T 472, L 263, F 61, S 8, H BU 1154, I/A 18 (17.11.11).
Nombramientos — 13/02/2009
Nombramientos. Aud.C.Con.: CONSULTOR OFFICE ZARAGOZA SL. Datos registrales. T 472, L 263, F 61, S 8, H BU 1154, I/A 17 ( 3.02.09).