Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 14 tarjetas
21/01/2019 Sec. I Disolución Madrid
Madrid-23865

Disolución — 21/01/2019

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 26921 , F 131, S 8, H M 485137, I/A 40 (11.01.19).

02/12/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-489405

Ceses/dimisiones — 02/12/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ PRIETO ANA. Nombramientos. Consejero: GARCIA CHOZAS MARTA. Datos registrales. T 26921 , F 127, S 8, H M 485137, I/A 35 (22.11.16).

10/05/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-201424

Nombramientos — 10/05/2016

Nombramientos. Apoderado: FAINE DE GARRIGA JAVIER. Datos registrales. T 26921 , F 125, S 8, H M 485137, I/A 34 ( 3.05.16).

04/05/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-191979

Nombramientos — 04/05/2016

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA CHOZAS MARTA. Datos registrales. T 26921 , F 123, S 8, H M 485137, I/A 32 (26.04.16).

19/10/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-418256

Nombramientos — 19/10/2015

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ MINGO JORGE LUIS. Datos registrales. T 26921 , F 121, S 8, H M 485137, I/A 29 ( 9.10.15).

19/10/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-418257

Nombramientos — 19/10/2015

Nombramientos. Apo.Man.Soli: PINO VALLADARES ANTONIO MARIA. Datos registrales. T 26921 , F 122, S 8, H M 485137, I/A 30 ( 9.10.15).

16/10/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-416248

Nombramientos — 16/10/2015

Nombramientos. Apoderado: JARQUE URIBE CARLOS MANUEL. Datos registrales. T 26921 , F 118, S 8, H M 485137, I/A 28 ( 7.10.15).

23/06/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-256902

Revocaciones — 23/06/2015

Revocaciones. Apoderado: CRESPO IZQUIERDO MIGUEL. Datos registrales. T 26921 , F 117, S 8, H M 485137, I/A 26 (11.06.15).

14/11/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-462086

Ceses/dimisiones — 14/11/2014

Ceses/Dimisiones. Presidente: FCC CONSTRUCCION SA. Consejero: FCC CONSTRUCCION SA;COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES SA;SINCLER SA. Vicepresid.: SINCLER SA. Consejero: EUROPEA DE GESTION SA. Vicesecret.: LOPEZ...

19/12/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-542997

Revocaciones — 19/12/2013

Revocaciones. Apoderado: GARCIA OREA ALVAREZ ALVARO. Datos registrales. T 26921 , F 110, S 8, H M 485137, I/A 16 (12.12.13).

02/12/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-513328

Revocaciones — 02/12/2013

Revocaciones. Apoderado: JANICES PEREZ JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 26921 , F 110, S 8, H M 485137, I/A 15 (22.11.13).

13/12/2012 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-519177

Reelecciones — 13/12/2012

Reelecciones. Consejero: COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES SA;SINCLER SA. Vicepresid.: SINCLER SA. Consejero: EUROPEA DE GESTION SA. Datos registrales. T 26921 , F 103, S 8, H M 485137, I/A 9 ( 5.12.12).

24/03/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-133091

Ceses/dimisiones — 24/03/2011

Ceses/Dimisiones. Representan: OLIVER GARCIA JOSE MARIA. Nombramientos. Representan: LOPEZ BARRANCO CRISTINA. Datos registrales. T 26921 , F 102, S 8, H M 485137, I/A 4 (15.03.11).

21/01/2009 Sec. I Ampliacion del objeto social Guadalajara
Guadalajara-31078

Ampliacion del objeto social — 21/01/2009

Ampliacion del objeto social. a- Realizar por sí, o administrar y promocionar por cuenta de terceros, lacompraventa, almacenamiento o distribución de carburantes, lubrificantes, combustibles, recambios, reparaciones y t...