Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 5 tarjetas
20/09/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-382935

Ceses/dimisiones — 20/09/2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: DAWSON JOHN. Presidente: DAWSON JOHN. Nombramientos. Consejero: DUGGAN ALEXANDER JAMES HANBURY. Presidente: BUTTERFIELD PETER JONATHAN. Datos registrales. T 35210 , F 26, S 8, H M 633161, I/...

31/10/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-438635

Nombramientos — 31/10/2016

Nombramientos. SecreNoConsj: FAUS SANTASUSANA JORDI. VsecrNoConsj: ROBINSON SARAH. Presidente: DAWSON JOHN. VsecrNoConsj: MARESMA CASELLAS MERCE. Datos registrales. T 35210 , F 23, S 8, H M 633161, I/A 2 (20.10.16).

31/10/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-438636

Nombramientos — 31/10/2016

Nombramientos. Apoderado: SILVA CASTILLO LUIS. Datos registrales. T 35210 , F 23, S 8, H M 633161, I/A 3 (20.10.16).

31/10/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-438637

Nombramientos — 31/10/2016

Nombramientos. Apoderado: FAUS SANTASUSANA JORDI;XAVIER MOLINER BERNADES;SUAREZ FERNANDEZ JUAN;RODELLAR TORRAS EDUARD;ARANEGA MUÑOZ FRANCISCO;MARESMA CASELLAS MERCE. Datos registrales. T 35210 , F 25, S 8, H M 633161, I...

24/10/2016 Sec. I Constitución Madrid
Madrid-426754

Constitución — 24/10/2016

Constitución. Comienzo de operaciones: 4.08.16. Objeto social: 1. El objeto social de la sociedad es el desarrollo, fabricación, registro, almacenamiento, comercialización, promoción, importación y exportación de medica...