Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 5 tarjetas
13/03/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-109811

Nombramientos — 13/03/2015

Nombramientos. Apoderado: ARELLANO GONZALEZ JORGE. Datos registrales. T 29634 , F 62, S 8, H M 215899, I/A 97 ( 5.03.15).

11/02/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-67182

Ceses/dimisiones — 11/02/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ DONOSO JOSE LUIS. Datos registrales. T 29634 , F 60, S 8, H M 215899, I/A 91 ( 4.02.13).

26/12/2012 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-537669

Reelecciones — 26/12/2012

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 29634 , F 59, S 8, H M 215899, I/A 90 (18.12.12).

31/07/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-321508

Nombramientos — 31/07/2012

Nombramientos. Apoderado: PINEDO MOYA PEDRO ANGEL. Datos registrales. T 29634 , F 57, S 8, H M 215899, I/A 86 (19.07.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 145 Martes 31 de julio de 2012 Pág. 35030 cve: BORME-...

20/04/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-175387

Nombramientos — 20/04/2012

Nombramientos. Apoderado: BUESA GARCIA PEDRO. Datos registrales. T 29634 , F 56, S 8, H M 215899, I/A 84 (10.04.12).