Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 20 tarjetas
28/09/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Teruel
Teruel-391973

Ceses/dimisiones — 28/09/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: MORTE MURILLO JORGE ALBERTO;PEREZ DIES SANTIAGO. Presidente: PEREZ DIES SANTIAGO. Consejero: VIVAS SAURA MIGUEL ANDRES. Secretario: NOLASCO GOMEZ JOSE MANUEL. Disolución. Fusion. BOLETÍN OFI...

04/08/2016 Sec. I Sociedad unipersonal Teruel
Teruel-323882

Sociedad unipersonal — 04/08/2016

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: SIERRA DE CEDRILLAS SL. Datos registrales. T 230, L 230, F 108, S 8, H TE 4525, I/A 22 (22.07.16).

18/06/2015 Sec. I Ampliación de capital Teruel
Teruel-248849

Ampliación de capital — 18/06/2015

Ampliación de capital. Capital: 1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.800.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 7 .- Se fija el capital social de la Sociedad en 2.800.000 eu...

06/11/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Teruel
Teruel-448876

Ceses/dimisiones — 06/11/2014

Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUILAR GIMENO JOAQUIN PASCUAL;VICENTE PASCUAL JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: VIVAS SAURA MIGUEL ANDRES. Datos registrales. T 230, L 230, F 107, S 8, H TE 4525, I/A 18 (14.10.14).

06/11/2014 Sec. I Revocaciones Teruel
Teruel-448877

Revocaciones — 06/11/2014

Revocaciones. Apo.Manc.: VIVAS SAURA MIGUEL ANDRES;VICENTE PASCUAL JOSE LUIS. Datos registrales. T 230, L 230, F 107, S 8, H TE 4525, I/A 19 (14.10.14).

06/11/2014 Sec. I Nombramientos Teruel
Teruel-448878

Nombramientos — 06/11/2014

Nombramientos. Apo.Manc.: VIVAS SAURA MIGUEL ANDRES;MORTE MURILLO JORGE ALBERTO;PEREZ DIES SANTIAGO. Datos registrales. T 230, L 230, F 107, S 8, H TE 4525, I/A 20 (14.10.14).

30/10/2014 Sec. I Declaración de unipersonalidad Teruel
Teruel-438341

Declaración de unipersonalidad — 30/10/2014

Declaración de unipersonalidad. Socio único: TERRA VALIS SL. Datos registrales. T 230, L 230, F 48, S 8, H TE 4525, I/A 16 (14.10.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 208 Jueves 30 de octubre de 2014 Pág. 47...

30/10/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Teruel
Teruel-438342

Ceses/dimisiones — 30/10/2014

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA RURAL DE TERUEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDI. Datos registrales. T 230, L 230, F 107, S 8, H TE 4525, I/A 17 (14.10.14). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.:...

11/06/2014 Sec. I Revocaciones Teruel
Teruel-245873

Revocaciones — 11/06/2014

Revocaciones. Apoderado: IZQUIERDO ESCUDER MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 230, L 230, F 48, S 8, H TE 4525, I/A 15 (26.05.14).

22/05/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Teruel
Teruel-217166

Ceses/dimisiones — 22/05/2014

Ceses/Dimisiones. Consejero: RANERA GONZALEZ CARLOS EMILIO. Datos registrales. T 230, L 230, F 48, S 8, H TE 4525, I/A 14 ( 5.05.14).

16/04/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Teruel
Teruel-170667

Ceses/dimisiones — 16/04/2014

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS PALOMAR SALVADOR;SANCHEZ HERNANDEZ JUAN. Nombramientos. Consejero: AGUILAR GIMENO JOAQUIN PASCUAL;VICENTE PASCUAL JOSE LUIS. Datos registrales. T 230, L 230, F 48, S 8, H TE 4525, I/A...

20/03/2014 Sec. I Reelecciones Teruel
Teruel-127630

Reelecciones — 20/03/2014

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 230, L 230, F 36, S 8, H TE 4525, I/A 12 (20.02.14).

05/06/2013 Sec. I Revocaciones Teruel
Teruel-258995

Revocaciones — 05/06/2013

Revocaciones. Apoderado: HERRERA LOPEZ LUCIANO. Datos registrales. T 230, L 230, F 36, S 8, H TE 4525, I/A 11 (27.05.13). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 104 Miércoles 5 de junio de 2013 Pág. 27578 cve: BORM...

17/04/2013 Sec. I Reelecciones Teruel
Teruel-182096

Reelecciones — 17/04/2013

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 228, L 228, F 224, S 8, H TE 4525, I/A 9 (27.03.13).

17/04/2013 Sec. I Nombramientos Teruel
Teruel-182097

Nombramientos — 17/04/2013

Nombramientos. Apo.Manc.: VIVAS SAURA MIGUEL ANDRES;VICENTE PASCUAL JOSE LUIS. Datos registrales. T 230, L 230, F 36, S 8, H TE 4525, I/A 10 ( 5.04.13).

20/03/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Teruel
Teruel-133884

Ceses/dimisiones — 20/03/2013

Ceses/Dimisiones. Presidente: GARCES GAMBARO CLEMENTE. Nombramientos. Presidente: PEREZ DIES SANTIAGO. Datos registrales. T 228, L 228, F 224, S 8, H TE 4525, I/A 8 (12.03.13). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGI...

11/09/2012 Sec. I Nombramientos Teruel
Teruel-373018

Nombramientos — 11/09/2012

Nombramientos. Apoderado: IZQUIERDO ESCUDER MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 228, L 228, F 214, S 8, H TE 4525, I/A 7 ( 6.07.12).

21/05/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Teruel
Teruel-214081

Ceses/dimisiones — 21/05/2012

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARCES GAMBARO CLEMENTE. Nombramientos. Secretario: NOLASCO GOMEZ JOSE MANUEL. Consejero: MORTE MURILLO JORGE ALBERTO;PEREZ DIES SANTIAGO;CAMPOS PALOMAR SALVADOR;RANERA GONZALEZ CARLOS EMIL...

08/10/2010 Sec. I Nombramientos Teruel
Teruel-377559

Nombramientos — 08/10/2010

Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 228, L 228, F 214, S 8, H TE 4525, I/A 5 (30.09.10).

14/05/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Teruel
Teruel-195303

Ceses/dimisiones — 14/05/2010

Ceses/Dimisiones. Secretario: NOLASCO GOMEZ JOSE MANUEL. Consejero: GARCES GAMBARO CLEMENTE;INVERSIONES DOGARMATER SL;TUROL DIVERSIA SL;FRANCOIS PINEL PHILIPPE THIERRY. Presidente: GARCES GAMBARO CLEMENTE. Con.Delegado:...