Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 6 tarjetas
17/11/2016 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-466135

Nombramientos — 17/11/2016

Nombramientos. Apoderado: HERRERO HERNANDO JOSE LUIS. Datos registrales. T 3425 , F 220, S 8, H Z 23725, I/A 14 ( 8.11.16).

09/04/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-158502

Ceses/dimisiones — 09/04/2014

Ceses/Dimisiones. Apo.Sol.: VELA BLASCO BLANCA. Datos registrales. T 3425 , F 220, S 8, H Z 23725, I/A 13 ( 2.04.14).

24/02/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-85956

Ceses/dimisiones — 24/02/2014

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CRUZ CEJUDO FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Unico: LOPEZ MADRAZO HERNANDEZ JORGE. Datos registrales. T 3425 , F 220, S 8, H Z 23725, I/A 12 (14.02.14).

11/05/2012 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-204310

Revocaciones — 11/05/2012

Revocaciones. Apo.Sol.: MAINAR RUIZ DELFIN. Datos registrales. T 3425 , F 220, S 8, H Z 23725, I/A 11 (28.04.12).

09/02/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-55881

Ceses/dimisiones — 09/02/2010

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOPEZ-MADRAZO GONZALEZ MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Adm. Unico: CRUZ CEJUDO FRANCISCO. Datos registrales. T 3336 , F 219, S 8, H Z 23725, I/A 10 (28.01.10).

30/12/2009 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-543993

Nombramientos — 30/12/2009

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ-MADRAZO HERNANDEZ JORGE. Datos registrales. T 3336 , F 223, S 8, H Z 23725, I/A 9 (18.12.09).