Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 19 tarjetas
07/10/2019 Sec. I Extinción Madrid
Madrid-415666

Extinción — 07/10/2019

Extinción. Datos registrales. T 35486 , F 73, S 8, H M 319367, I/A 42 (30.09.19).

06/09/2019 Sec. I Otros conceptos: TRASLADADO EL DOMICILIO SOCIAL A CLAUDE DEBUSSYLAAN 12, 1082 MD, AMSTERDAM, PAISES BAJOS Madrid
Madrid-383342

Otros conceptos: trasladado el domicilio social a claude debussylaan 12, 1082 md, amsterdam, paises bajos — 06/09/2019

Otros conceptos: TRASLADADO EL DOMICILIO SOCIAL A CLAUDE DEBUSSYLAAN 12, 1082 MD, AMSTERDAM, PAISES BAJOS. Datos registrales. T 35486 , F 72, S 8, H M 319367, I/A 41M (30.08.19).

03/09/2019 Sec. I Sociedad unipersonal Madrid
Madrid-378287

Sociedad unipersonal — 03/09/2019

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: AES GLOBAL POWER HOLDINGS BV. Datos registrales. T 35486 , F 72, S 8, H M 319367, I/A 41 (27.08.19).

05/03/2019 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-101882

Revocaciones — 05/03/2019

Revocaciones. Apo.Sol.: MOREIRA VILLAN THIAGO JOSE;MOREIRA VILLAN THIAGO JOSE. Apo.Manc.: MOREIRA VILLAN THIAGO JOSE. Apoderado: MOREIRA VILLAN THIAGO JOSE;MOREIRA VILLAN THIAGO JOSE;MOREIRA VILLAN THIAGO JOSE Nombramie...

31/01/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-45370

Ceses/dimisiones — 31/01/2019

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MOREIRA VILLAN THIAGO JOSE. Nombramientos. Adm. Mancom.: NUÑEZ DE PEREZ ENMA MARCELLIES. Datos registrales. T 35486 , F 70, S 8, H M 319367, I/A 39 (24.01.19).

25/01/2019 Sec. I Declaración de unipersonalidad Madrid
Madrid-34920

Declaración de unipersonalidad — 25/01/2019

Declaración de unipersonalidad. Socio único: THE AES CORPORATION. Datos registrales. T 35486 , F 69, S 8, H M 319367, I/A 38 (18.01.19).

13/07/2017 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-288931

Revocaciones — 13/07/2017

Revocaciones. Apoderado: FICARA FICARA FRANCISCO. Datos registrales. T 35486 , F 69, S 8, H M 319367, I/A 36 ( 4.07.17).

26/05/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-220158

Ceses/dimisiones — 26/05/2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: FICARA FICARA FRANCISCO;MOREIRA VILLAN THIAGO JOSE. Vicepresid.: MOREIRA VILLAN THIAGO JOSE. Consejero: AQUINO PAZ ELENISE. Presidente: AQUINO PAZ ELENISE. Secretario: MILLAN CRUZ MARIA DEL...

26/05/2017 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-220159

Modificaciones estatutarias — 26/05/2017

Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO VIGESIMO NOVENO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 35486 , F 67, S 8, H M 319367, I/A 33 (18.05.17). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 98 Viern...

26/05/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-220160

Nombramientos — 26/05/2017

Nombramientos. Apoderado: MILLAN CRUZ MARIA DEL CARMEN;HOYA DE MARIA BEATRIZ;MOLINA LOPEZ MARIA DE LOS MILAGROS;CATALA MARTINEZ ROCIO. Datos registrales. T 35486 , F 68, S 8, H M 319367, I/A 34 (18.05.17).

26/05/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-220161

Nombramientos — 26/05/2017

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ GONZALEZ ANA. Datos registrales. T 35486 , F 68, S 8, H M 319367, I/A 35 (18.05.17).

21/04/2017 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-173820

Cambio de domicilio social — 21/04/2017

Cambio de domicilio social. C/ BRAVO MURILLO 101 - 5ª PLANTA, PUERTA 1 (MADRID). Datos registrales. T 35486 , F 64, S 8, H M 319367, I/A 27 (12.04.17).

30/03/2017 Sec. I Otros conceptos: Modificación del artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales Murcia
Murcia-144711

Otros conceptos: modificación del artículo vigésimo noveno de los estatutos sociales — 30/03/2017

Otros conceptos: Modificación del artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 2820 , F 152, S 8, H MU 75138, I/A 20 (24.03.17). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.:...

13/01/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Murcia
Murcia-18729

Ceses/dimisiones — 13/01/2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: BERNERD RAYMOND DA SANTOS AVILA;FRANCISCO JAVIER DIAZ DE BUSTAMANTE TERMINEL. Presidente: BERNERD RAYMOND DA SANTOS AVILA. Vicepresid.: FRANCISCO JAVIER DIAZ DE BUSTAMANTE TERMINEL. Datos re...

13/01/2017 Sec. I Nombramientos Murcia
Murcia-18730

Nombramientos — 13/01/2017

Nombramientos. Consejero: ELENISE AQUINO PAZ. Presidente: ELENISE AQUINO PAZ. Consejero: THIAGO JOSE MOREIRA VILLAN. Vicepresid.: THIAGO JOSE MOREIRA VILLAN. Datos registrales. T 2820 , F 151, S 8, H MU 75138, I/A 19 (...

27/11/2015 Sec. I Nombramientos Murcia
Murcia-482791

Nombramientos — 27/11/2015

Nombramientos. Apo.Sol.: BERNERD RAYMOND DA SANTOS AVILA;FRANCISCO FICARA FICARA;FRANCISCO JAVIER DIAZ DE BUSTAMANTE TERMINEL. Datos registrales. T 2820 , F 151, S 8, H MU 75138, I/A 15 (20.11.15).

27/11/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Murcia
Murcia-482792

Ceses/dimisiones — 27/11/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: TAJADURA GARRIDO JOSE MARIA. Vicepresid.: TAJADURA GARRIDO JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: FRANCISCO JAVIER DIAZ DE BUSTAMANTE TERMINEL. Vicepresid.: FRANCISCO JAVIER DIAZ DE BUSTAMANT...

27/11/2015 Sec. I Revocaciones Murcia
Murcia-482793

Revocaciones — 27/11/2015

Revocaciones. Apo.Manc.: JOSE MARIA TAJADURA GARRIDO. Datos registrales. T 2820 , F 151, S 8, H MU 75138, I/A 17 (20.11.15).

25/11/2014 Sec. I Reelecciones Murcia
Murcia-480655

Reelecciones — 25/11/2014

Reelecciones. Auditor: VAHN Y CIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 2820 , F 151, S 8, H MU 75138, I/A 14 (18.11.14).