Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 6 tarjetas
19/02/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-76671

Ceses/dimisiones — 19/02/2019

Ceses/Dimisiones. Consejero: MELLENTIN GUSTAV CHRISTEN;JURICIC STEFAN;BAK JAKOB TOFTGAARD. Presidente: MELLENTIN GUSTAV CHRISTEN. Secretario: JURICIC STEFAN. Cons.Del.Sol: MELLENTIN GUSTAV CHRISTEN. Nombramientos. Adm....

07/12/2017 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-480102

Cambio de domicilio social — 07/12/2017

Cambio de domicilio social. C/ ALCALA 21 10 I (MADRID). Datos registrales. T 30323 , F 93, S 8, H M 545819, I/A 8 (28.11.17).

03/04/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-148544

Nombramientos — 03/04/2017

Nombramientos. Apoderado: MARTIN MARTIN SERGIO. Datos registrales. T 30323 , F 92, S 8, H M 545819, I/A 7 (24.03.17).

05/02/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-52744

Nombramientos — 05/02/2016

Nombramientos. Cons.Del.Sol: MELLENTIN GUSTAV CHRISTEN. Datos registrales. T 30323 , F 91, S 8, H M 545819, I/A 5 (28.01.16).

31/03/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-137401

Nombramientos — 31/03/2015

Nombramientos. Apo.Sol.: VON CARSTENN-LICHTERFELDE MENENDEZ FERNANDO. Cambio de domicilio social. C/ ORENSE, NUMERO 34, PLANTA 10, IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 30323 , F 90, S 8, H M 545819, I/A 2 (23.03.15).

31/03/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-137402

Nombramientos — 31/03/2015

Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ-GIL MARTIN MIGUEL. Datos registrales. T 30323 , F 90, S 8, H M 545819, I/A 3 (23.03.15).