Actos destacados
Ceses/dimisiones — 09/10/2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: KARWOWSKA ANNA. Nombramientos. Consejero: MOYANO SANCHEZ ALBERTO. Presidente: MOYANO SANCHEZ ALBERTO. Consejero: FERNANDEZ PARRA DAVID. Secretario: FERNANDEZ PARRA DAVID. Consejero: FERNAND...
Nombramientos — 18/07/2017
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ PARRA DAVID;FERNANDEZ RAMOS JESUS MANUEL;MOYANO SANCHEZ ALBERTO. Datos registrales. T 818 , F 134, S 8, H LO 17339, I/A 4 (10.07.17).
Ceses/dimisiones — 26/06/2017
Ceses/Dimisiones. Apoderado: RAYA DEMIDOFF DANIEL. Datos registrales. T 818 , F 134, S 8, H LO 17339, I/A 3 ( 6.06.17).
Cambio de domicilio social — 24/01/2017
Cambio de domicilio social. C/ LOPE DE VEGA 43-45 - VIVERO DE EMPRESAS DE LA A (LOGROÑO). Datos registrales. T 818 , F 131, S 8, H LO 17339, I/A 1 ( 9.01.17).
Cambio de domicilio social — 24/01/2017
Cambio de domicilio social. C/ LOPE DE VEGA 43-45 (LOGROÑO). Datos registrales. T 818 , F 134, S 8, H LO 17339, I/A 2 ( 9.01.17).
Cambio de domicilio social — 10/05/2016
Cambio de domicilio social. C/ SANTIAGO GRISOLIA 2 (TRES CANTOS). Datos registrales. T 34612 , F 146, S 8, H M 622718, I/A 2 (29.04.16).
Ampliación de capital — 10/05/2016
Ampliación de capital. Capital: 297,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.297,00 Euros. Datos registrales. T 34612 , F 146, S 8, H M 622718, I/A 3 ( 3.05.16).
Revocaciones — 23/11/2015
Revocaciones. ADM.UNICO: RAYA DEMIDOFF DANIEL. Nombramientos. ADM.UNICO: RAYA DEMIDOFF JAVIER. Datos registrales. T 44568 , F 222, S 8, H B 460228, I/A 4 (16.11.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 223 Lunes...
Nombramientos — 23/11/2015
Nombramientos. APODERAD.SOL: RAYA DEMIDOFF DANIEL. Datos registrales. T 44568 , F 222, S 8, H B 460228, I/A 6 (16.11.15).