Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2009 4 tarjetas
04/09/2009 Sec. I Revocaciones Córdoba
Córdoba-383165

Revocaciones — 04/09/2009

Revocaciones. Apoderado: MACARRON LEAL CAMILO BERNADO. Datos registrales. T 1540 , F 222, S 8, H CO 16654, I/A 22 (26.08.09).

19/06/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-276421

Ceses/dimisiones — 19/06/2009

Ceses/Dimisiones. Apoderado: GONZALEZ FERNANDEZ NIETO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1540 , F 222, S 8, H CO 16654, I/A 21 ( 9.06.09).

20/03/2009 Sec. I Nombramientos Córdoba
Córdoba-139001

Nombramientos — 20/03/2009

Nombramientos. Apoderado: PEREZ AGUILAR JOSE LUIS. Apo.Manc.: PEREZ AGUILAR JOSE LUIS;LOPEZ JURADO FRANCISCO. Datos registrales. T 1540 , F 220, S 8, H CO 16654, I/A 18 (10.03.09).

20/03/2009 Sec. I Cambio de domicilio social Córdoba
Córdoba-139002

Cambio de domicilio social — 20/03/2009

Cambio de domicilio social. POLIG LAS QUEMADAS - PARCELA 259-C (CORDOBA). Datos registrales. T 1540 , F 221, S 8, H CO 16654, I/A 19 (10.03.09). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990...