Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2012 5 tarjetas
18/12/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Jaén
Jaén-524602

Ceses/dimisiones — 18/12/2012

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CAÑO GONZALEZ LUIS MANUEL. Nombramientos. Liquidador: CAÑO GONZALEZ LUIS MANUEL. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 339 , F 100, S 8, H J 12595, I/A 10 (11.12.12).

25/01/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Jaén
Jaén-35655

Ceses/dimisiones — 25/01/2012

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DE LA TORRE RODRIGUEZ ANTONIO JOAQUIN. Nombramientos. Adm. Unico: CAÑO GONZALEZ LUIS MANUEL. Datos registrales. T 339 , F 100, S 8, H J 12595, I/A 9 (16.01.12).

13/12/2011 Sec. I Declaración de unipersonalidad Jaén
Jaén-493944

Declaración de unipersonalidad — 13/12/2011

Declaración de unipersonalidad. Socio único: SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA VIRGEN DEL PERPETUO. Datos registrales. T 339 , F 100, S 8, H J 12595, I/A 8 (30.11.11). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTI...

02/11/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Jaén
Jaén-434702

Ceses/dimisiones — 02/11/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: LA TORRE RODRIGUEZ ANTONIO;GUERRERO ZAPATA RAFAEL;SANCHEZ AREVALO FRANCISCO. Presidente: LA TORRE RODRIGUEZ ANTONIO. Consejero: GARCIA PADILLA FRANCISCO. Vicesecret.: GARCIA PADILLA FRANCISC...

18/12/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Jaén
Jaén-526156

Ceses/dimisiones — 18/12/2009

Ceses/Dimisiones. Consejero: TEJERO JIMENEZ MANUEL. Nombramientos. Consejero: LOPEZ MOYA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 339 , F 98, S 8, H J 12595, I/A 6 (10.12.09).