Actos destacados
Nombramientos — 06/06/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ RICO XOAN XOSE;LOPEZ SUEVOS OTERO MARIA;GARCES GRELA MARIA VICTORIA;PEREIRA ADRIO MARTA;DEL VALLE RUIZ ORTIZ DELIANA;GARZON PASCUAL DE RIQUELME ANGEL ENRIQUE;GARZON PASCUAL DE RIQUELME...
Ampliación de capital — 12/01/2016
Ampliación de capital. Capital: 37.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 886.528.500,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5.- Relativo al capital social.. Datos registrales. T 3453 , F 223,...
Nombramientos — 21/04/2015
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3453 , F 222, S 8, H C 44719, I/A 134 ( 8.04.15).
Nombramientos — 24/03/2015
Nombramientos. Apo.Manc.: AYDILLO ASTORGA ALBERTO;PONTE MARTINEZ EDUARDO;FERREIRO VIVERO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3453 , F 219, S 8, H C 44719, I/A 129 (16.03.15).
Revocaciones — 24/03/2015
Revocaciones. Apo.Manc.: ROMERO QUIROGA JOSE LUIS. Datos registrales. T 3453 , F 220, S 8, H C 44719, I/A 130 (16.03.15).
Nombramientos — 24/03/2015
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ MARTINEZ ROBERTO. Datos registrales. T 3453 , F 220, S 8, H C 44719, I/A 131 (16.03.15).
Nombramientos — 24/03/2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: AYDILLO ASTORGA ALBERTO;PONTE MARTINEZ EDUARDO;DE LA TORRE MIGUEZ EDUARDO;CASTAÑON LOPEZ MARCOS-DANIEL;INFANTE NOGUEIRA MARIA;PEREZ VALCARCE JAVIER. Datos registrales. T 3453 , F 221, S 8, H...
Nombramientos — 24/03/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ GARCIA GONZALO. Datos registrales. T 3453 , F 221, S 8, H C 44719, I/A 132 (16.03.15).
Revocaciones — 10/02/2015
Revocaciones. Apo.Sol.: MEDINA FRAILE ERIKA. Datos registrales. T 3453 , F 217, S 8, H C 44719, I/A 126 ( 2.02.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 27 Martes 10 de febrero de 2015 Pág. 6054 cve: BORME-A-2015...