Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 11 tarjetas
04/04/2019 Sec. I Disolución Madrid
Madrid-151541

Disolución — 04/04/2019

Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 27100 , F 126, S 8, H M 121019, I/A 54 (28.03.19).

17/05/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-208289

Revocaciones — 17/05/2018

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ECHART AROCENA PABLO JOSE. Datos registrales. T 27100 , F 126, S 8, H M 121019, I/A 53 ( 8.05.18).

02/01/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-1086

Revocaciones — 02/01/2018

Revocaciones. Apo.Sol.: NEWMAN ANGELA LOUISE. Apo.Manc.: MARTIN JENNIFER ELLA. Nombramientos. Apo.Sol.: FREEMAN AMY;DICKSON LYNSEY;CASHIN NICHOLA MICHELLE. Datos registrales. T 27100 , F 125, S 8, H M 121019, I/A 51 (20...

02/01/2018 Sec. I Otros conceptos: Dimisión de DOÑA ANGELA LOUISE VIDLER, como consejera de la sociedad "3i EUROPE PLC", con efecto a partir del 26 de septiembre de 2017 Madrid
Madrid-1087

Otros conceptos: dimisión de doÑa angela louise vidler, como consejera de la sociedad "3i europe plc", con efecto a partir del 26 de septiembre de 2017 — 02/01/2018

Otros conceptos: Dimisión de DOÑA ANGELA LOUISE VIDLER, como consejera de la sociedad "3i EUROPE PLC", con efecto a partir del 26 de septiembre de 2017. Datos registrales. T 27100 , F 126, S 8, H M 121019, I/A 52 (21.12...

07/12/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-496199

Revocaciones — 07/12/2015

Revocaciones. Apoderado: GARDNER CLAIRE NADINE. Datos registrales. T 27100 , F 124, S 8, H M 121019, I/A 48 (27.11.15).

01/04/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-139335

Revocaciones — 01/04/2015

Revocaciones. Apoderado: MICHERO CARLO. Nombramientos. Apo.Sol.: CARNIMOLLA REMI JEAN LOUIS. Apoderado: GARDNER CLAIRE NADINE. Datos registrales. T 27100 , F 120, S 8, H M 121019, I/A 44 (24.03.15).

01/04/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-139336

Revocaciones — 01/04/2015

Revocaciones. Apo.Manc.: BOSHELL FFION LOWRI. Apoderado: VIDAL-QUADRAS DE CARALT ALEJO. Datos registrales. T 27100 , F 122, S 8, H M 121019, I/A 45 (24.03.15).

27/03/2013 Sec. I Otros conceptos: - CESE DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD MATRIZ "3i EUROPE PLC": DON MENNO ANTAL, con fecha 24 de Septiembre de 2012 Madrid
Madrid-147812

Otros conceptos: - cese de miembros del consejo de la sociedad matriz "3i europe plc": don menno antal, con fecha 24 de septiembre de 2012 — 27/03/2013

Otros conceptos: - CESE DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD MATRIZ "3i EUROPE PLC": DON MENNO ANTAL, con fecha 24 de Septiembre de 2012. DON JOHAN SEGER, con fecha 2 de OCtubre de 2012. DON CARLO MICHERO, con fecha 2...

03/05/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-190451

Nombramientos — 03/05/2012

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ HERNANDEZ ABELARDO. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 30& LA PUBLICACION DEL PODER OTORGADO A LOPEZ HERNANDEZ ABELARDO. Datos registrales. T 13379 , F 162, S 8, H M 121...

03/05/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-190452

Revocaciones — 03/05/2012

Revocaciones. Apoderado: HEAPPEY MARK. Datos registrales. T 27100 , F 117, S 8, H M 121019, I/A 38 (19.04.12).

04/05/2010 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-179886

Revocaciones — 04/05/2010

Revocaciones. Apoderado: PLA VILA AGUSTIN;HEAPPEY MARK. Apo.Man.Soli: QUEMADA SAENZ-BADILLO JORGE;LOPEZ HERNANDEZ ABELARDO. Datos registrales. T 27100 , F 115, S 8, H M 121019, I/A 34 (22.04.10).