{"company":{"slug":"termica-afap-sa","name":"TERMICA AFAP SA","cif":"A45456480","website":"http:\/\/www.boe.es","capital":"","address":"","workers":"","status":"Activa","company_type":"S.A.","date_creation":"","aliases":["termica afap","termica afap sa"]},"kpis":{"acts_count":16,"first_seen":"2009-04-07","last_seen":"2019-05-13","province_count":1},"timeline":[{"period":"2009-04","count":1},{"period":"2010-04","count":1},{"period":"2010-07","count":1},{"period":"2011-06","count":1},{"period":"2012-07","count":1},{"period":"2013-03","count":1},{"period":"2013-04","count":1},{"period":"2013-12","count":1},{"period":"2015-02","count":1},{"period":"2015-06","count":1},{"period":"2015-07","count":1},{"period":"2015-09","count":1},{"period":"2016-02","count":1},{"period":"2019-02","count":2},{"period":"2019-05","count":1}],"top_event_types":[{"type":"Ceses\/Dimisiones","count":4},{"type":"Revocaciones","count":3},{"type":"Nombramientos","count":3},{"type":"Reducción de capital","count":1},{"type":"Otros conceptos:  Cesado el representante persona física del Consejero \"VISELPUERTAS SA\" y nombrado nuevo representante: D","count":1},{"type":"Otros conceptos:  Cambiado el representante persona física de la sociedad SIEMENS SA, designando a Don Javier Martínez Lázaro","count":1},{"type":"Otros conceptos:  MODIFICADO EL ARTICULO 7º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES","count":1},{"type":"Ampliación de capital","count":1}],"top_provinces":[{"province":"Toledo","count":16}],"events":[{"id":"Toledo-202897","date":"2019-05-13","year":"2019","section":"1","province":"Toledo","type":"Nombramientos","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Nombramientos.  Auditor: ERNST & YOUNG SL.  Datos registrales. T 1617 , F 140, S 8, H TO 15428, I\/A 36 ( 3.05.19)."},{"id":"Toledo-93460","date":"2019-02-27","year":"2019","section":"1","province":"Toledo","type":"Nombramientos","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Nombramientos.  Apoderado: DE SOLA-MORALES FELIU MARIA;LOPEZ FERNANDEZ RAQUEL. Apo.Manc.: SERRET HUARTE\nJUAN;DE SOLA-MORALES FELIU MARIA.  Datos registrales. T 1617 , F 139, S 8, H TO 15428, I\/A 34 (19.02.19)."},{"id":"Toledo-93461","date":"2019-02-27","year":"2019","section":"1","province":"Toledo","type":"Otros conceptos:  Modificados los artículos 15º, 5º y 6º de los estatutos sociales","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Otros conceptos:  Modificados los artículos 15º, 5º y 6º de los estatutos sociales.  Datos registrales. T 1617 , F 140, S 8, H TO\n15428, I\/A 35 (19.02.19)."},{"id":"Toledo-92271","date":"2016-02-29","year":"2016","section":"1","province":"Toledo","type":"Nombramientos","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Nombramientos.  Auditor: BDO AUDITORES SLP.  Datos registrales. T 1595 , F 96, S 8, H TO 15428, I\/A 33 (22.02.16)."},{"id":"Toledo-367278","date":"2015-09-08","year":"2015","section":"1","province":"Toledo","type":"Ceses\/Dimisiones","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Ceses\/Dimisiones.  Consejero: PUERTAS PROMA SA;PUERTAS SANRAFAEL SA;SIEMENS SA. Presidente: SIEMENS SA.\nConsejero: SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA. Secretario: SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO\nINDUSTRIAL DE CASTILLA.  Revocaciones.  Apo.Manc.: CHAVES ALONSO MARIA INMACULADA. Apo.Sol.: CHAVES ALONSO\nMARIA INMACULADA.  Nombramientos.  Consejero: CORTES RUIZ ANTONIO JUAN;SERRET HUARTE JUAN;DE SOLA-\nMORALES FELIU MARIA. Presidente: CORTES RUIZ ANTONIO JUAN. Secretario: DE SOLA-MORALES FELIU MARIA.\nCon.Del"},{"id":"Toledo-294302","date":"2015-07-16","year":"2015","section":"1","province":"Toledo","type":"Ampliación de capital","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Ampliación de capital.  Suscrito: 12.207.839,14 Euros. Desembolsado: 12.207.839,14 Euros. Resultante Suscrito: 16.937.937,38\nEuros. Resultante Desembolsado: 16.937.937,38 Euros.  Datos registrales. T 1595 , F 95, S 8, H TO 15428, I\/A 31 ( 8.07.15).\n294303 - GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA\nDE LA REINA SA.\nNombramientos.  Secretario: CORROCHANO GARCIA BARROSO MARIO.  Datos registrales. T 1440 , F 140, S 8, H TO 16735, I\/A\n10 ( 9.07.15)."},{"id":"Toledo-265196","date":"2015-06-26","year":"2015","section":"1","province":"Toledo","type":"Otros conceptos:  MODIFICADO EL ARTICULO 7º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Otros conceptos:  MODIFICADO EL ARTICULO 7º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.  Datos registrales. T 1595 , F 95, S 8, H TO\n15428, I\/A 30 (18.06.15).\nhttp:\/\/www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188\/1990 - ISSN: 0214-9958"},{"id":"Toledo-77369","date":"2015-02-20","year":"2015","section":"1","province":"Toledo","type":"Revocaciones","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Revocaciones.  Apo.Man.Soli: CHAVES ALONSO MARIA INMACULADA.  Nombramientos.  Apo.Sol.: CHAVES ALONSO MARIA\nINMACULADA. Apo.Manc.: CHAVES ALONSO MARIA INMACULADA.  Datos registrales. T 1502 , F 95, S 8, H TO 15428, I\/A 29\n(12.02.15)."},{"id":"Toledo-531545","date":"2013-12-12","year":"2013","section":"1","province":"Toledo","type":"Ceses\/Dimisiones","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Ceses\/Dimisiones.  Consejero: PUERTAS ARTEVI SA;REVENGA MARTINEZ TEOFILO.  Nombramientos.  Consejero: PUERTAS\nSANRAFAEL SA;PUERTAS PROMA SA.  Datos registrales. T 1502 , F 88, S 8, H TO 15428, I\/A 26 ( 4.12.13)."},{"id":"Toledo-155733","date":"2013-04-03","year":"2013","section":"1","province":"Toledo","type":"Revocaciones","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Revocaciones.  Apoderado: MIGUEZ GOMEZ CLAUDIO DANIEL.  Nombramientos.  Apoderado: ZARATE ECHEVERRIA\nFRANCISCO DE BORJA.  Datos registrales. T 1502 , F 88, S 8, H TO 15428, I\/A 25 (25.03.13)."},{"id":"Toledo-148364","date":"2013-03-27","year":"2013","section":"1","province":"Toledo","type":"Revocaciones","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Revocaciones.  Apoderado: MIGUEZ GOMEZ CLAUDIO DANIEL.  Nombramientos.  Apo.Sol.: ZARATE ECHEVERRIA FRANCISCO\nDE BORJA. Apo.Manc.: ZARATE ECHEVERRIA FRANCISCO DE BORJA.  Datos registrales. T 1502 , F 87, S 8, H TO 15428, I\/A 24\n(19.03.13)."},{"id":"Toledo-282827","date":"2012-07-04","year":"2012","section":"1","province":"Toledo","type":"Ceses\/Dimisiones","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Ceses\/Dimisiones.  Consejero: VISEL PUERTAS SA EN LIQUIDACION. Vicepresid.: PUERTAS ARTEVI SA.  Nombramientos.\nPresidente: SIEMENS SA.  Reelecciones.  Consejero: REVENGA MARTINEZ TEOFILO;PUERTAS ARTEVI SA;SIEMENS\nSA;SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA. Secretario: SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL\nBOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL\nNúm. 126 Miércoles 4 de julio de 2012 Pág. 30844\ncve: BORME-A-2012-126-45\nDE CASTILLA.  Datos registrales. T 1502 , F 87, S 8, H TO 15428, I\/A 23 (25.06.12)."},{"id":"Toledo-255207","date":"2011-06-14","year":"2011","section":"1","province":"Toledo","type":"Otros conceptos:  Cambiado el representante persona física de la sociedad SIEMENS SA, designando a Don Javier Martínez Lázaro","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Otros conceptos:  Cambiado el representante persona física de la sociedad SIEMENS SA, designando a Don Javier Martínez Lázaro.\nDatos registrales. T 1502 , F 87, S 8, H TO 15428, I\/A 22 ( 2.06.11)."},{"id":"Toledo-296882","date":"2010-07-28","year":"2010","section":"1","province":"Toledo","type":"Otros conceptos:  Cesado el representante persona física del Consejero \"VISELPUERTAS SA\" y nombrado nuevo representante: D","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Otros conceptos:  Cesado el representante persona física del Consejero \"VISELPUERTAS SA\" y nombrado nuevo representante: D.\nRaimundo-Antonio García Martín.  Datos registrales. T 1408 , F 138, S 8, H TO 15428, I\/A 21 (15.07.10)."},{"id":"Toledo-155682","date":"2010-04-19","year":"2010","section":"1","province":"Toledo","type":"Reducción de capital","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Reducción de capital.  Importe reducción: 1.725.316,02 Euros. Resultante Suscrito: 3.707.305,56 Euros.  Ampliación de capital.\nSuscrito: 1.022.792,68 Euros. Desembolsado: 1.022.792,68 Euros. Resultante Suscrito: 4.730.098,24 Euros. Resultante\nDesembolsado: 4.730.098,24 Euros.  Datos registrales. T 1408 , F 138, S 8, H TO 15428, I\/A 20 ( 6.04.10)."},{"id":"Toledo-171561","date":"2009-04-07","year":"2009","section":"1","province":"Toledo","type":"Ceses\/Dimisiones","title":"TERMICA AFAP SA","details":"Ceses\/Dimisiones.  Consejero: PUERTAS SAN RAFAEL SA.  Nombramientos.  Consejero: REVENGA MARTINEZ TEOFILO.  Otros\nconceptos:  Cambiado el representante persona física del consejero \"VISEL PUERTAS SA\" designando como tal a D& Sonia Soliva\nParadis en sustitución de D& Juan M& Almendros Camuñas.  Datos registrales. T 1408 , F 137, S 8, H TO 15428, I\/A 19 (27.03.09)."}],"officers":{"current":[{"name":"PUERTAS SAN RAFAEL SA","person_slug":"puertas-san-rafael-sa","role":"Consejero","since":"2009-04-07"},{"name":"REVENGA MARTINEZ TEOFILO","person_slug":"revenga-martinez-teofilo","role":"Consejero","since":"2012-07-04"},{"name":"VISEL PUERTAS SA EN LIQUIDACION","person_slug":"visel-puertas-sa-en-liquidacion","role":"Consejero","since":"2012-07-04"},{"name":"SIEMENS SA","person_slug":"siemens-sa","role":"Presidente","since":"2015-09-08"},{"name":"SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL","person_slug":"sociedad-para-el-desarrollo-industrial","role":"Secretario","since":"2012-07-04"},{"name":"MIGUEZ GOMEZ CLAUDIO DANIEL","person_slug":"miguez-gomez-claudio-daniel","role":"Apoderado","since":"2013-04-03"},{"name":"ZARATE ECHEVERRIA","person_slug":"zarate-echeverria","role":"Apoderado","since":"2013-04-03"},{"name":"PUERTAS ARTEVI SA","person_slug":"puertas-artevi-sa","role":"Consejero","since":"2013-12-12"},{"name":"PUERTAS","person_slug":"puertas","role":"Consejero","since":"2013-12-12"},{"name":"CORROCHANO GARCIA BARROSO MARIO","person_slug":"corrochano-garcia-barroso-mario","role":"Secretario","since":"2015-07-16"},{"name":"PUERTAS PROMA SA","person_slug":"puertas-proma-sa","role":"Consejero","since":"2015-09-08"},{"name":"SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA","person_slug":"sociedad-para-el-desarrollo-industrial-de-castilla","role":"Consejero","since":"2015-09-08"},{"name":"SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO","person_slug":"sociedad-para-el-desarrollo","role":"Secretario","since":"2015-09-08"},{"name":"CORTES RUIZ ANTONIO JUAN","person_slug":"cortes-ruiz-antonio-juan","role":"Consejero","since":"2015-09-08"},{"name":"CORTES RUIZ ANTONIO JUAN","person_slug":"cortes-ruiz-antonio-juan","role":"Presidente","since":"2015-09-08"},{"name":"DE SOLA-MORALES FELIU MARIA","person_slug":"de-sola-morales-feliu-maria","role":"Secretario","since":"2015-09-08"},{"name":"BDO AUDITORES SLP","person_slug":"bdo-auditores-slp","role":"Auditor","since":"2016-02-29"},{"name":"DE SOLA-MORALES FELIU MARIA","person_slug":"de-sola-morales-feliu-maria","role":"Apoderado","since":"2019-02-27"},{"name":"ERNST","person_slug":"ernst","role":"Auditor","since":"2019-05-13"}],"historical":[]},"summary_text":"TERMICA AFAP SA: 16 actos registrados. Primera aparicion 2009-04-07, ultima aparicion 2019-05-13. Actividad en 1 provincias."}